THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL

THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC155050
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    • Autres hébergements (55900) / Hébergement et restauration

    Où se situe THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Adresse du siège social
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL LIMITED01 nov. 202401 nov. 2024
    RONALD MCDONALD HOUSE GLASGOW30 mars 201730 mars 2017
    YORKHILL FAMILY HOUSE LIMITED20 déc. 199420 déc. 1994

    Quels sont les derniers comptes de THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au20 déc. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation03 janv. 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au20 déc. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modification des coordonnées du secrétaire Ms Geraldine Moreau le 22 nov. 2025

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 20 déc. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2025

    39 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Charles Wilson le 30 mai 2025

    2 pagesCH01

    Nomination de Ms Geraldine Moreau en tant que secrétaire le 01 août 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alison Lyn Gardner en tant que secrétaire le 01 août 2025

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Neil Morrison en tant que secrétaire le 01 nov. 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Brian Gallacher en tant que directeur le 08 avr. 2025

    1 pagesTM01

    Nomination de Dr Christopher John Kidson en tant qu'administrateur le 06 janv. 2025

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 20 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2024 au 31 mars 2025

    1 pagesAA01

    Nomination de Ms Melanie Hutton en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed the house at glasgow children’s hospital LIMITED\certificate issued on 13/11/24
    2 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 nov. 2024

    Exemption de changement de nom" de l'utilisation de "limitée" ou "cyfyngedig"

    NE01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Notification de Glasgow Children’S Hospital Charity en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 nov. 2024

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 04 nov. 2024

    2 pagesPSC09

    Nomination de Ms Alison Lyn Gardner en tant que secrétaire le 04 nov. 2024

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de Ronald Mcdonald House Glasgow 1299 Govan Road Glasgow G51 4TE Scotland à 1299 Govan Road Glasgow G51 4TE le 04 nov. 2024

    1 pagesAD01

    Nomination de Mrs Delia Marie Henry en tant qu'administrateur le 01 nov. 2024

    2 pagesAP01

    Statuts

    21 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed ronald mcdonald house glasgow\certificate issued on 01/11/24
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 nov. 2024

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de George Adam Edward Buchanan-Smith en tant que directeur le 14 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALKER, Geraldine
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Secrétaire
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    339016530002
    ALI, Atif
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish121513200001
    HENRY, Delia Marie
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish87121930001
    HUTTON, Melanie
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish313985980001
    KIDSON, Christopher John, Dr
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish331399240001
    KING, Kevin
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandScottish290746150001
    KIRKNESS, Gillian
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish148739890002
    MCCUDDEN, Michael Thomas
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish118453530001
    MILLAR, Lesley-Mari
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish231410940001
    MORRISON, Neil
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish4949350001
    PITTS, John Francis Armstrong, Dr
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    EnglandBritish68261570006
    WILSON, Paul Charles
    Glengoyne Court
    East Kilbride
    G75 8BT Glasgow
    23
    Scotland
    Administrateur
    Glengoyne Court
    East Kilbride
    G75 8BT Glasgow
    23
    Scotland
    ScotlandBritish290747080002
    ANDERSON, John Watson
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Secrétaire
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    British45376650001
    GARDNER, Alison Lyn
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Secrétaire
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    328927260001
    MORRISON, Neil
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Secrétaire
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    286216630001
    SLATER, John Arthur Glascock
    22 Hamilton Court
    Hamilton Road
    W5 2EJ Ealing
    Secrétaire
    22 Hamilton Court
    Hamilton Road
    W5 2EJ Ealing
    British41899760001
    ANDERSON, John Watson
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish45376650001
    ARONSON, Clive Joseph
    Whitelodge 28 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Whitelodge 28 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish357180004
    BLACK, Colin Jeffrey
    9 Laigh Road
    Newton Mearns
    G77 5EX Glasgow
    Administrateur
    9 Laigh Road
    Newton Mearns
    G77 5EX Glasgow
    ScotlandBritish699600001
    BOYLE, Iain
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    ScotlandScottish195842550001
    BUCHANAN-SMITH, George Adam Edward
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish155155470002
    CALDERWOOD, Meryl Anne, Lady
    6 Mosspark Avenue
    Milngavie
    G62 8NL Glasgow
    Administrateur
    6 Mosspark Avenue
    Milngavie
    G62 8NL Glasgow
    British41557260001
    CLARK, William David
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish5423770009
    CRUSHER, Ann Margaret
    Craigievar Place
    Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    4
    Scotland
    Administrateur
    Craigievar Place
    Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    4
    Scotland
    ScotlandBritish250434020001
    GALLACHER, Brian
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish106683270001
    GARNER, Gwendoline Elizabeth Jane
    33 Meadowhill
    Newton Mearns
    G77 6SZ Glasgow
    Administrateur
    33 Meadowhill
    Newton Mearns
    G77 6SZ Glasgow
    United KingdomBritish41557400001
    GIBSON, Andrew Shearer
    14 Baldernock Road
    G62 8DU Milngavie
    Administrateur
    14 Baldernock Road
    G62 8DU Milngavie
    United KingdomBritish41557190003
    GILLIES, Marjorie Love
    Ronald Mcdonald House
    61 Esmond Street
    G3 8SL Glasgow
    Administrateur
    Ronald Mcdonald House
    61 Esmond Street
    G3 8SL Glasgow
    United KingdomBritish104084310001
    GOEL, Krishna Murari, Dr
    Eredine House
    Lochaweside
    PA33 1BP Eredine
    By Dalmally,Argyll
    Administrateur
    Eredine House
    Lochaweside
    PA33 1BP Eredine
    By Dalmally,Argyll
    British33392630002
    GRANT, Colin Cameron
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    ScotlandBritish235506700001
    HARDIE, Josephine Alma
    Ronald Mcdonald House
    61 Esmond Street
    G3 8SL Glasgow
    Administrateur
    Ronald Mcdonald House
    61 Esmond Street
    G3 8SL Glasgow
    ScotlandBritish184820230001
    KELLY, Thomas
    45 De Walden Drive
    KA3 6AA Kilmarnock
    Administrateur
    45 De Walden Drive
    KA3 6AA Kilmarnock
    British107003630002
    MARTIN, Eleanor
    51b Montrose Drive
    Bearsden
    G61 3JY Glasgow
    Administrateur
    51b Montrose Drive
    Bearsden
    G61 3JY Glasgow
    United KingdomBritish41557320001
    MCAULEY, Mary
    Ronald Mcdonald House
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    Administrateur
    Ronald Mcdonald House
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    1299
    Scotland
    ScotlandBritish179038740002
    MCCORKINDALE, Donald Gordon
    81 Finlay Rise Fairways
    Milngavie
    G62 6QL Glasgow
    East Dunbartonshire
    Scotland
    Administrateur
    81 Finlay Rise Fairways
    Milngavie
    G62 6QL Glasgow
    East Dunbartonshire
    Scotland
    British50011350003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Marchfield Drive
    PA3 2RB Paisley
    Ground Floor, Merrylee House, 8
    Scotland
    01 nov. 2024
    Marchfield Drive
    PA3 2RB Paisley
    Ground Floor, Merrylee House, 8
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementUnited Kingdom
    Numéro d'enregistrementSc222439
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une fiducie, et les fiduciaires de cette fiducie (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr John Watson Anderson
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    08 déc. 2016
    1299 Govan Road
    G51 4TE Glasgow
    Ronald Mcdonald House Glasgow
    Scotland
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour THE HOUSE AT GLASGOW CHILDREN’S HOSPITAL ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    12 août 202101 nov. 2024La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0