BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD.
Vue d'ensemble
| Nom de la société | BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC155147 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| Adresse du siège social | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 19 déc. 2025 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 02 janv. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 19 déc. 2024 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 11 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Jemma Fallon May Brown en tant que directeur le 24 oct. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Charles Price le 20 déc. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 7-9 North St David's Street 7-9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW Scotland à Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE le 29 sept. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Notification de Bright Purple Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mai 2023 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Nicholas Charles Price en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mai 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Peter Paul Flaherty en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 mai 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 9 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Peter Paul Flaherty en tant que directeur le 19 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Christopher Peter Murphy en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Notification de Nicholas Charles Price en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 août 2022 | 2 pages | PSC01 | ||
Cessation de Ide International Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 août 2022 | 1 pages | PSC07 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2022 | 8 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Matthew John Angus Tedstone en tant que directeur le 19 août 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2021 avec mises à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2021 | 8 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 7-9 North St David's Street 7-9 North St David's Street Edinburgh EH3 1AW United Kingdom à 7-9 North St David's Street 7-9 North St. David Street Edinburgh EH2 1AW le 17 mai 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de The Eagle Building 19 Rose Street Edinburgh EH2 2PR à 7-9 North St David's Street 7-9 North St David's Street Edinburgh EH3 1AW le 27 avr. 2021 | 1 pages | AD01 | ||
Modifications à la charge flottante SC1551470004 | 11 pages | 466(Scot) | ||
Modifications à la charge flottante SC1551470005 | 14 pages | 466(Scot) | ||
Déclaration de confirmation établie le 19 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRICE, Nicholas Charles | Secrétaire | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | 263930410001 | |||||||
| MURPHY, Christopher Peter | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | Scotland | Irish | 287544470001 | |||||
| PRICE, Nicholas Charles | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | 42754890003 | |||||
| WEBSTER, Kane Watt | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | Scotland | Scottish | 275163080001 | |||||
| BALLANTYNE SMITH, Gillian | Secrétaire | 22 Braid Avenue EH10 6EE Edinburgh | British | 60121810001 | ||||||
| MACLEAN, Alastair Finlay | Secrétaire | 37 North Gyle Avenue EH12 8JR Edinburgh | British | 52467400001 | ||||||
| REID, Brian | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park EH7 4HH Edinburgh | British | 900007130001 | ||||||
| SMITH, Thomas Alan | Secrétaire | 22 Braid Avenue EH10 6EE Edinburgh | British | 42754900003 | ||||||
| BALLANTYNE SMITH, Gillian | Administrateur | 22 Braid Avenue EH10 6EE Edinburgh | Scotland | British | 60121810001 | |||||
| BROWN, Jemma Fallon May | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | Scotland | Scottish | 275162610001 | |||||
| CURRY, Paul | Administrateur | Rose Street EH2 2PR Edinburgh 19 Scotland | Scotland | British | 235323900001 | |||||
| DYER, Cyril Alexander | Administrateur | 19 Rose Street EH2 2PR Edinburgh The Eagle Building | United Kingdom | British | 112480480002 | |||||
| ELLIS, Simon David Ronald | Administrateur | 19 Rose Street EH2 2PR Edinburgh The Eagle Building | England | British | 210469200001 | |||||
| FLAHERTY, Peter Paul | Administrateur | Lyndenhurst 19 Village Way Dulwich SE21 7AN London | United Kingdom | British | 51777380006 | |||||
| HALL, George Brown | Administrateur | 69 Orchard Brae Avenue EH4 2UR Edinburgh Mid Lothian | United Kingdom | British | 77555500001 | |||||
| HEYWOOD, Tessa Miranda | Administrateur | Flat 1/2 20 Cordiner Street G44 4TY Glasgow | Scotland | British | 110594930001 | |||||
| JUNOR, William Taylor | Administrateur | Whitestone Cargill PH2 6DT Perth | Scotland | British | 38975210002 | |||||
| LAFFERTY, Neil Cornelius | Administrateur | 4th Floor, The Eagle Building 19 Rose Street EH2 2PR Edinburgh | United Kingdom | British | 135634040001 | |||||
| MABBOTT, Stephen | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | Scotland | British | 900008380001 | |||||
| MACLEAN, Alastair Finlay | Administrateur | 37 North Gyle Avenue EH12 8JR Edinburgh | Scotland | British | 52467400001 | |||||
| MCCLOREY, Katherine Lee | Administrateur | 3 Sylvan Place EH9 1LH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 116640580001 | |||||
| MUTCH, Jan Elizabeth | Administrateur | 35 Lauder Road EH9 2JG Edinburgh | Scotland | British | 56103690001 | |||||
| SMITH, Thomas Alan | Administrateur | 22 Braid Avenue EH10 6EE Edinburgh | United Kingdom | British | 42754900003 | |||||
| SUMMERS, Tony | Administrateur | Calle Finlandia Chiclana 11130 Cadiz 13 Spain | Spain | British | 188419260001 | |||||
| SUMMERS, Tony | Administrateur | Chiclana 11130 Calle Finlandia 13 Cadiz | Spain | British | 129960190001 | |||||
| TEDSTONE, Matthew John Angus | Administrateur | 7-9 North St. David Street EH2 1AW Edinburgh 7-9 North St David's Street Scotland | England | British | 239140470001 | |||||
| TILLMAN PRICE, Lilian Margita | Administrateur | 10/3 Dean Path EH4 3BA Edinburgh | British | 41549680001 | ||||||
| WHELAN, Yvonne | Administrateur | 63 High Street EH49 7ED Linlithgow West Lothian | Scotland | British | 101198610001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRIGHT PURPLE RESOURCING LTD. ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Purple Holdings Limited | 18 mai 2023 | Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange, 19a Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Nicholas Charles Price | 26 août 2022 | 7-9 North St. David Street EH2 1AW Edinburgh 7-9 North St David's Street Scotland | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: Scotland | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Mr Peter Paul Flaherty | 06 avr. 2016 | 7-9 North St. David Street EH2 1AW Edinburgh 7-9 North St David's Street Scotland | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Ide International Ltd | 06 avr. 2016 | Quarrywood Court EH47 8NT Livinston Argyll House West Lothian Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0