SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC155408
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    • (1598) /

    Où se situe SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Third Floor West Edinburgh Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SPEYSIDE GLENLIVIT WATER COMPANY LIMITED21 mars 199521 mars 1995
    M M & S (2247) LIMITED18 janv. 199518 janv. 1995

    Quels sont les derniers comptes de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans CVL

    12 pagesLIQ14(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de * Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG* le 13 mars 2013

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * 2Nd Floor, Capital House 2 Festival Square Edinburgh Midlothian EH3 9SU* le 25 janv. 2012

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * Invocas 2Nd Floor, Langstane House 221/229 Union Street Aberdeen AB11 6DR* le 15 avr. 2011

    2 pagesAD01

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    11 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.20B(Scot)

    legacy

    2 pages2.18B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    8 pages2.20B(Scot)

    legacy

    19 pages2.18B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    13 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages410(Scot)

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2006

    14 pagesAA

    legacy

    42 pages363a

    legacy

    3 pages88(2)R

    legacy

    1 pages288c

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2005

    15 pagesAA

    legacy

    6 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages419a(Scot)

    legacy

    42 pages363a

    legacy

    3 pages88(2)R

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Secrétaire
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    British7130710001
    DRESHER, Leontina Megan
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Chilworth Springs
    Chilworth Farm
    OX44 7JH Great Milton
    Oxfordshire
    United KingdomHungarian30141330001
    PRICE, Stephen
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Willows
    Water Stratford
    MK18 5DU Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish73146560001
    ROSS, Gavin Maxwell
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    Administrateur
    Cheriton The Glade
    TN20 6AT Mayfield
    East Sussex
    EnglandBritish7130710001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Secrétaire
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    British70901470001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Secrétaire
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    British61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    British57563390001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    British74298510001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secrétaire
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Secrétaire
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    British14578540001
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    ANDERSON, John Arthur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    Administrateur
    Manx Farm Steep Hill
    Chobham
    GU24 8SZ Woking
    Surrey
    EnglandBritish34883320001
    BEVAN, Jonathan Stuart Vaughan
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    Administrateur
    1 Eaton Gate
    SW1W 9BA London
    British39232450001
    CHILD, Peter John
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    Administrateur
    3 Danson Mead
    DA16 1RU Welling
    Kent
    British24036010001
    CLARK, Patricia Ann
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    Administrateur
    Penponds House
    Tregavethan
    TR4 9EJ Truro
    Cornwall
    British68375010001
    COURTNEY, John Adam
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    70west Riding
    Bricket Wood
    AL2 3QQ St Albans
    Hertfordshire
    British15297560005
    CUTHBERT, Bernice Margaret
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Aston Park Stud
    Aston Rowant
    OX49 5SR Watlington
    Oxfordshire
    United KingdomBritish70901470001
    EVERETT, Grace Mary
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    British70901230001
    EVERETT, Timothy John
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    Administrateur
    Ashley Farmhouse
    Ashley, Kings Somborne
    SO20 6RQ Stockbridge
    Hampshire
    United KingdomBritish70901170001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Administrateur
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritish38497170001
    HEINRICH, Gisbert
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    Administrateur
    15 Windsor Close
    Read
    BB12 7QH Burnley
    Lancashire
    British44530030001
    HELLIWELL, David
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    Administrateur
    53 Bonython Road
    TR7 3AL Newquay
    Cornwall
    EnglandBritish61424220001
    KINLOCH, Henry, Dr
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Manor House
    Newton
    PE13 5EL Wisbech
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish57563390001
    MARNER, Christian
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    Kingwood Stud
    Lambourn Woodlands
    RG17 7RS Hungerford
    Berkshire
    Danish52354890003
    MILLAR, Andrew Donaldson
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    Administrateur
    29 Ferncroft Avenue
    Hampstead
    NW3 7PG London
    British116870001
    SMITH, Lindsay Meredith
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    Administrateur
    93 Highgate West Hill
    Highgate
    N6 6EH London
    United KingdomBritish14578540001
    SULLY, Malcolm Keith
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    4 Northwood Drive
    HA6 2YU Northwood
    Middlesex
    British39278310002
    WOOD - ROBERTS, David
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    Administrateur
    West Knole House
    Knole
    TA10 9HY Langport
    Somerset
    British64744510006
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 12 mars 2008
    Livré le 02 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Floating charge over 1 x 2007 zambelli fully automatic trayloader/shrink wrapping machine, model number LFT20/v single lane version - serial number 4621.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Commercial Asset Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 02 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 02 nov. 2006
    Livré le 22 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    As continuing security for the payment or discharge othe secured liabilities all of the equipment and other chattels. See form 410 for further details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Davenham Trust PLC
    Transactions
    • 22 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 avr. 2004
    Livré le 14 mai 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 10 sept. 1999
    Livré le 23 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Speyside Glenlivet Limited
    Transactions
    • 23 sept. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SPEYSIDE GLENLIVET WATER COMPANY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 mars 2009Administration started
    04 mars 2010Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    practitioner
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    practitioner
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    2
    DateType
    04 mars 2010Commencement of winding up
    14 nov. 2020Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Andrew Albert Murdoch
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    practitioner
    2nd Floor Langstane House
    221-229 Union Street
    AB11 6DR Aberdeen
    Donald Iain Mcnaught
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    practitioner
    221-229 Union Street
    Langstane House
    AB11 6DR Aberdeen
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0