BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED

BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC155811
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MORRISON RESIDENTIAL ASSETS LIMITED11 mars 199611 mars 1996
    ADERWOOD LIMITED07 févr. 199507 févr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Modification des coordonnées du secrétaire Terrace Hill (Secretaries) Limited le 28 oct. 2015

    1 pagesCH04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    12 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Martin Austen le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Alexander Jeremy Leech le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 févr. 2015

    État du capital au 09 févr. 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN* le 23 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 févr. 2014

    État du capital au 12 févr. 2014

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Cessation de la nomination de Thomas Walsh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Miranda Kelly en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Jonathan Martin Austen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Philip Alexander Jeremy Leech en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Qui sont les dirigeants de BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC154216
    41006000014
    AUSTEN, Jonathan Martin
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish51921200001
    LEECH, Philip Alexander Jeremy
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    EnglandBritish77080490002
    BLACK, Lysanne Jane Warren
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    Secrétaire
    6 Belgrave Crescent
    EH4 3AQ Edinburgh
    British46707740002
    FERRIE, Joyce
    11 Seaside Place
    Aberdour
    KY3 0TX Burntisland
    Fife
    Secrétaire
    11 Seaside Place
    Aberdour
    KY3 0TX Burntisland
    Fife
    British34749860002
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MACRAE, Alistair Ian
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    32 The Steils
    EH10 5XD Edinburgh
    Midlothian
    British71950710001
    ROBERTSON, John William
    52 Findhorn Place
    EH9 2NS Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    52 Findhorn Place
    EH9 2NS Edinburgh
    Midlothian
    British61404440001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    QUEENSFERRY SECRETARIES LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011040001
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish9150920001
    DONNELLY, Anthony
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    Administrateur
    1 Old Kirk Road
    Corstorphine
    EH12 6JY Edinburgh
    United KingdomBritish109258700001
    HUTCHISON, Graeme
    17 Ladysmith Road
    EH9 3EX Edinburgh
    Administrateur
    17 Ladysmith Road
    EH9 3EX Edinburgh
    British38185540001
    HUTCHISON, Graeme
    17 Ladysmith Road
    EH9 3EX Edinburgh
    Administrateur
    17 Ladysmith Road
    EH9 3EX Edinburgh
    British38185540001
    KELLY, Miranda Anne
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    Administrateur
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    ScotlandBritish62817160003
    LEITH, Brian James
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    Administrateur
    10 Douglas Avenue
    Lenzie
    G66 4NW Glasgow
    British61660001
    MACDONALD, Donald Ross
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    Administrateur
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    United KingdomBritish76786510001
    MACKAY, Ewan William
    17 Potassels Road
    Muirhead
    G69 9EL Chryston
    Administrateur
    17 Potassels Road
    Muirhead
    G69 9EL Chryston
    British64627230001
    MCDONALD, Derek
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    Administrateur
    8 Glen Sannox Grove
    Craigmarloch
    G68 0GH Cumbernauld
    ScotlandBritish190466700001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Administrateur
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritish33622580001
    MCDOWALL, June Patricia
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    Administrateur
    139 Hamilton Road
    Rutherglen
    G73 3BE Glasgow
    United KingdomBritish50316470001
    MIDDLETON, Douglas Alister
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    Administrateur
    16 Wesley Crescent
    Bonnyrigg
    EH19 3RT Edinburgh
    British73738070001
    PRICHARD, Kim Alan
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Pentland Gardens
    EH10 6NW Edinburgh
    Midlothian
    British72744060002
    ROBB, Gordon William
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    7 High Buckstone
    Fairmilehead
    EH10 6XS Edinburgh
    Midlothian
    British11456230001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Administrateur
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    EnglandIrish48520230001
    WILSON, Alistair Barclay
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    British426640001
    QUEENSFERRY FORMATIONS LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011030001
    QUEENSFERRY REGISTRATIONS LIMITED
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    Administrateur désigné
    Orchard Brae House
    30 Queensferry Road
    EH4 2HG Edinburgh
    Lothian
    900011020001

    BELGRAVE RESIDENTIAL ASSETS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 16 mai 2004
    Livré le 04 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    G3, F5, F6, S5, S6 & A2 at 22 alexandra gate, neilston road, paisley ren 114293 REN114294 REN114295 REN114296 ren 114297 REN114299.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 04 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 30 avr. 2004
    Livré le 10 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming flats 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E and 22F inchinnan court, inchinnan road, paisley (title number ren 65186) and 6 garages on the ground floor of the tenement 14 to 26 inchinnan court (title number ren 76285).
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 11 déc. 2001
    Livré le 28 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    25,26 and 27 riverside drive, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 28 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 2001
    Livré le 12 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    140 oxford street & 14 south portland street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 2001
    Livré le 12 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    32 flatted dwellinghouses at 2 belmont street, glasgow & 482,484 & 486 great western road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 12 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 juin 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 2001
    Livré le 11 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    27 flatted dwellinghouses at 31-57 spoolers road, paisley.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 avr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1-35 bloomfield court, aberdeen (excluding number 13).
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot S82-93 strawberry bank, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 2001
    Livré le 10 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects know as cherrytree mill and cherrytree house, 50/56 strathleven place, dumbarton.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 11 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 57 to 62 cotgreen road, tweedbank, galashiels, roxburgh.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 27 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 10 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot of ground extending to 4366.67 square metres lying generally to the northwest of the centre line of slaon avenue, irvine; together with the whole buildings erected thereon known as 1 to 4 sloan place, irvine.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 06 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    130,132 & 134 gylemuir road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 03 déc. 2001
    Livré le 06 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    170,172,176 & 178 gylemuir road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 mars 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 nov. 2001
    Livré le 29 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 29 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 déc. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 avr. 2003Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 05 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 11 sept. 2000
    Livré le 13 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond by the company dated 18TH march 1996
    Brèves mentions
    18 flatted dwellinghouses at 26 riverside drive, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 13 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16 flatted dwellinghouses at 24 & 25 riverside drive, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 avr. 2000
    Livré le 19 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Various flats at 27 riverside drive, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 02 oct. 1998
    Livré le 22 oct. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    61 & 63 whitworth street,manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 oct. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 mars 1998
    Livré le 06 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over blocks a & e anchorage quay,salford quays,manchester. See the mortgage charge document for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 avr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 13 févr. 1998
    Livré le 23 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Development site at the junction of oxford street & south portland street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 déc. 1997
    Livré le 15 déc. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground southwest of maxwellton road,paisley.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 déc. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 30 sept. 1997
    Livré le 03 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    34 residential units at gylemeadow, gylemuir road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 oct. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 28 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 82 to 93 of the development at strawberry bank/glenberry mews,aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Homes
    Transactions
    • 28 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 09 avr. 1997
    Livré le 16 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 22 to 55 of a development at hardgate/bloomfield road,aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Homes
    Transactions
    • 16 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 juin 2012Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    • 03 août 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 24 mars 1997
    Livré le 26 mars 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property comprising the development site at restalrig drive,edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 mars 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 déc. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0