FIRSTGROUP PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRSTGROUP PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC157176
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRSTGROUP PLC ?

    • Transport ferroviaire de voyageurs interurbain (49100) / Transports et stockage
    • Autre transport terrestre de voyageurs urbain, suburbain ou métropolitain (hors métro, métro léger et systèmes similaires) (49319) / Transports et stockage

    Où se situe FIRSTGROUP PLC ?

    Adresse du siège social
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRSTGROUP PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIRSTBUS PLC31 mars 199531 mars 1995

    Quels sont les derniers comptes de FIRSTGROUP PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour FIRSTGROUP PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 janv. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 janv. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 janv. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRSTGROUP PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes intermédiaires établis au 27 sept. 2025

    4 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,533,800.8
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,567,411.4
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    10 nov. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate stamp duty was paid in relation to the repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,504,633.6
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,470,785
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 oct. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,433,741.2
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,396,195.45
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 oct. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,346,848.05
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    30 sept. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,261,811.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    22 sept. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,209,311.5
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    17 sept. 2025Clarification HMRC confirmation received that the appropriate duty has been paid in relation to this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,173,224.95
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    09 sept. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 9,040,316.15
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,789,688.15
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,926,483.5
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres.

    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    06 août 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'actions propres sur capital

    RES08
    capital

    Résolutions

    Section 366 and 367 authority to make political donations. Approval of the firstgroup PLC sharesave plan 2025. that a general meeting other than an agm may be called on not less than 14 clear days notice. 25/07/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,679,877.35
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    31 juil. 2025Clarification HMRC confirmation has been received that the appropriate stamp duty has been paid in relation to this transaction.

    Cessation de la nomination de Anthony Charles Green en tant que directeur le 25 juil. 2025

    1 pagesTM01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,613,725.9
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    21 juil. 2025Clarification HMRC CONFIRMATION HAS BEEN RECEIVED THAT THE APPROPRIATE STAMP DUTY HAS BEEN PAID IN RELATION TO THIS TRANSACTION.

    Comptes consolidés établis au 29 mars 2025

    223 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,546,239.1
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,411,472.25
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,255,941.35
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,135,952.15
    4 pagesSH03

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 8,012,097.95
    4 pagesSH03

    Qui sont les dirigeants de FIRSTGROUP PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLIZZARD, David John Mark
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Secrétaire
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    294327710001
    CABRINI, Sally Joanne
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    EnglandBritish264630560002
    DAWES, Myrtle May
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    ScotlandBritish291486160001
    HAWKINGS, Claire Louise
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point
    England
    Administrateur
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point
    England
    EnglandBritish250071500001
    LODGE, Jane Ann
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    United KingdomBritish24341880002
    LYNAS, Peter
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    EnglandBritish285197840001
    MANGOLD, Ryan Dirk
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor, The Point
    United Kingdom
    Administrateur
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor, The Point
    United Kingdom
    United KingdomSouth African,British259031400001
    SUTHERLAND, Graham
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Northern IrelandBritish295841990001
    WILSON, Lena Cooper
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Administrateur
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    United KingdomBritish331983800001
    BARRIE, Sidney
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    British86630001
    CRANE, Julia Alison
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point
    England
    Secrétaire
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    The Point
    England
    291710070001
    HAMPSON, Michael
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    210877490001
    HUBBER, Keith Michael
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor, The Point
    United Kingdom
    Secrétaire
    37 North Wharf Road
    W2 1AF London
    8th Floor, The Point
    United Kingdom
    264418290001
    ISENEGGER, David
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    Secrétaire
    395 King Street
    Aberdeen
    AB24 5RP
    277123040001
    LEWIS, Paul Michael
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    161875930001
    OSBALDISTON, John Anthony
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Ashley House
    Manor Road
    HP10 8HY Penn
    Buckinghamshire
    British100098300001
    RUPPEL, Brenda Louise
    26 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    Secrétaire
    26 Broadhinton Road
    SW4 0LT London
    British59744930003
    WARD, David John
    Top Flat 27 Cotham Grove
    Cotham
    BS6 6AN Bristol
    Secrétaire
    Top Flat 27 Cotham Grove
    Cotham
    BS6 6AN Bristol
    British1535540001
    WELCH, Robert John
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Secrétaire
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    187821410001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    ADAM, Richard John
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    United Kingdom
    United KingdomBritish67133560004
    AHLERS, Keith Norman
    7 Burnbrae Road
    West Parley
    BH22 8RL Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    7 Burnbrae Road
    West Parley
    BH22 8RL Wimborne
    Dorset
    British12092360001
    BARCLAY, Robert Williamson
    Glenythan 37 Knockhall Road
    Newburgh
    AB41 0BJ Ellon
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Glenythan 37 Knockhall Road
    Newburgh
    AB41 0BJ Ellon
    Aberdeenshire
    British1227040002
    BARKER, Michael John
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    United KingdomBritish23878840001
    BARRIE, Sidney
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish86630001
    BARRIE, Sidney
    15 Kirk Brae Avenue
    Cults
    AB15 9RF Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    15 Kirk Brae Avenue
    Cults
    AB15 9RF Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish86630001
    BAXTER, Audrey Caroline
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    ScotlandScottish8987180006
    BEGG, David Andrew
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    EnglandBritish76645940003
    BRADY, Warwick
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Scotland
    EnglandBritish188844270002
    CARR, Jeffrey
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    Administrateur
    King Street
    AB24 5RP Aberdeen
    395
    Aberdeenshire
    EnglandBritish103780760001
    DUNCAN, Robert Alexander
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    Administrateur
    21 Rubislaw Den South
    AB15 4BD Aberdeen
    Scotland
    British48510002
    DUNN, David Moncrieff
    Longreach
    53 Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    Merseyside
    Administrateur
    Longreach
    53 Selworthy Road
    PR8 2HX Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish934610002
    FINCH, Dean Kendal
    Corrachree House
    Tarland
    AB34 4UP Aboyne
    Administrateur
    Corrachree House
    Tarland
    AB34 4UP Aboyne
    United KingdomBritish99214880001
    FORBES, James Alexander
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    Rydale Lodge
    1a Racecourse View
    KA7 2TS Ayr
    Ayrshire
    British141444100001
    FOREMAN, Cecil William
    Woodmead House Hascombe Road
    Hascombe
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Woodmead House Hascombe Road
    Hascombe
    GU8 4AD Godalming
    Surrey
    British22782400001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0