ALBYN HOSPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéALBYN HOSPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC157413
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Ross Hall Hospital
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GARDENFONT LIMITED12 avr. 199512 avr. 1995

    Quels sont les derniers comptes de ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital au 28 mars 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Catherine Mary Jane Vickery en tant que directeur le 30 nov. 2018

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Karen Anita Prins le 09 nov. 2018

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Catherine Mary Jane Vickery en tant que secrétaire le 30 nov. 2018

    1 pagesTM02

    Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2017 au 31 mars 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Dr Karen Anita Prins en tant qu'administrateur le 01 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jill Margaret Watts en tant que directeur le 30 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2016

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2015

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mai 2016

    État du capital au 16 mai 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Henry Jonathan Davies en tant qu'administrateur le 01 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Catherine Mary Jane Vickery en tant qu'administrateur le 01 mai 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Craig Barry Lovelace en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIES, Henry Jonathan
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    EnglandBritishFinance Director201206200001
    PRINS, Karen Anita, Dr
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    EnglandSouth AfricanChief Executive Officer238969330004
    COLLIER, Stephen John
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Secrétaire
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    BritishBarrister18350160001
    RUSSELL, Ronald
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    Secrétaire
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    ScottishAccountant9221920003
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Secrétaire
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    169336870001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Midlothian
    1198640001
    AULD, Charles Cairns
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    Administrateur
    2 Cheyne Row
    SW3 5HL London
    United KingdomBritishCompany Director23257420003
    CHAPPELL, Derek Guy
    43 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    Administrateur
    43 Hamilton Place
    AB15 4AX Aberdeen
    BritishChief Executive32697520003
    CHAPPELL, Derek Guy
    20 Argyll Place
    AB25 2EL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    20 Argyll Place
    AB25 2EL Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishChief Executive32697520002
    COLLIER, Stephen John
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    United KingdomBritishBarrister18350160001
    DAVIDSON, Lorne Montgomery
    2 Riverside Terrace
    AB10 7JD Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    2 Riverside Terrace
    AB10 7JD Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishMatron44428380001
    HAYES, Eugene Gerard
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    Administrateur
    42 West Heath Drive
    NW11 7QH London
    IrishCompany Director2464310004
    JANDIAL, Vijay, Dr
    29 Hazledene Road
    AB15 8LB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    29 Hazledene Road
    AB15 8LB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishConsultant65465630001
    JANDIAL, Vijay, Dr
    29 Hazledene Road
    AB15 8LB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    29 Hazledene Road
    AB15 8LB Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritishConsultant65465630001
    LOVELACE, Craig Barry
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    EnglandBritishChartered Accountant198852370001
    MASTERTON, Gordon Fraser
    2 Glenlockhart Valley
    EH14 1DE Edinburgh
    Administrateur
    2 Glenlockhart Valley
    EH14 1DE Edinburgh
    BritishHealth Care Management49610780001
    MURPHY, Paul
    Cunnery Farm Wychnor Park
    Burton-Under-Needwood
    DE13 8BU Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Cunnery Farm Wychnor Park
    Burton-Under-Needwood
    DE13 8BU Burton Upon Trent
    Staffordshire
    BritishCommercial Director103319780001
    RUSSELL, Ronald
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    Administrateur
    Drumforskie
    Bridge Of Dee
    AB12 5XJ Aberdeen
    ScotlandScottishAccountant9221920003
    SIMPSON DENT, Jonathan
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    Administrateur
    Carisbrook
    19 Briar Walk Putney
    SW15 6UD London
    United KingdomBritishDirector110396210002
    STEYN, John Hofmeyr
    3 Louisville Avenue
    AB15 4TT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    3 Louisville Avenue
    AB15 4TT Aberdeen
    Aberdeenshire
    BritishSurgeon22088980001
    VICKERY, Catherine Mary Jane
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    United KingdomBritishGeneral Counsel & Company Secretary102009810003
    WATTS, Jill Margaret
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    EnglandBritishGroup Chief Executive187252950001
    WIELAND, Phil
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Administrateur
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    United KingdomBritishFinance Director119448000002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    42728220001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALBYN HOSPITAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bmi Healthcare Scotland Limited
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Scotland
    06 avr. 2016
    221 Crookston Road
    G52 3NQ Glasgow
    Ross Hall Hospital
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueCompany Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies For Scotland
    Numéro d'enregistrementSc158515
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ALBYN HOSPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 09 oct. 2006
    Livré le 25 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 09 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 05 août 1999
    Livré le 17 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    21 albyn place, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transactions
    • 17 août 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 juin 1999
    Livré le 24 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abtrust Scotland Investment Company PLC
    Transactions
    • 24 juin 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 août 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 04 mai 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 28 août 1995
    Livré le 06 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    St johns private hospital complex at 21/24 albyn place, aberdeen.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 août 1995
    Livré le 25 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 août 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 août 1999Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 21 févr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0