KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED

KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéReceveur désigné
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC158115
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    • (7011) /

    Où se situe KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Atria One, 144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KILMARTIN PROPERTIES LIMITED18 mai 199518 mai 1995

    Quels sont les derniers comptes de KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 avr. 2009
    Date d'échéance des prochains comptes31 janv. 2010
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2008

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 mai 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation01 juin 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Changement d'adresse du siège social de * Erskine House, 2Nd Floor, 68-73 Queen Street Edinburgh Midlothian EH2 4NH* le 04 avr. 2014

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de * 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH United Kingdom* le 25 mars 2010

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Robert Wotherspoon en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Neil Mcguinness en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Avis de la nomination d'un séquestre par un détenteur d'une sûreté flottante

    2 pages1(Scot)

    Cessation de la nomination de Jonathan Ridehalgh en tant que directeur

    2 pagesTM01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes consolidés établis au 30 avr. 2008

    32 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    9 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    3 pages410(Scot)

    Qui sont les dirigeants de KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ORR, Martin
    2 Lothian Bank
    Dalkeith
    EH22 3AN Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    2 Lothian Bank
    Dalkeith
    EH22 3AN Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish114402810001
    URQUHART, Roderick Macduff
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    Secrétaire
    The Hall
    Samuelston
    EH41 4HG Haddington
    E Lothian
    British562500001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003420001
    BALL, Nicholas Spencer
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5 East Savile Road
    EH16 5ND Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish105270210001
    BOWDER, Simon Hugo
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Piggeries
    Hog Lane, Ashley Green
    HP5 3PS Chesham
    Buckinghamshire
    British105270120001
    BRYAN, James Hamilton
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    Administrateur
    95 Main Street
    Lyddington
    LE15 9LS Rutland
    Leicestershire
    United KingdomBritish149263980001
    FORSYTH, James Patrick Alistair
    21 Stonehill Road
    SW14 8RR London
    Administrateur
    21 Stonehill Road
    SW14 8RR London
    British127040003
    HANCOCK, Mark Edward
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Arncliffe
    BD23 5QD Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish141515870001
    JEPSON, Martin Clive
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    Administrateur
    5 Longcroft Avenue
    SM7 3AE Banstead
    Surrey
    United KingdomBritish92627900001
    KERR, Adam Charles
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    Administrateur
    Snail Hall Millwood Road
    Polstead
    CO6 5AU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish141326000001
    KERSHAW, Adrian
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    17 Summerside Street
    EH6 4NT Edinburgh
    Midlothian
    British116630690001
    MCGUINNESS, Neil Stephen
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    Administrateur
    Hazeldean Avenue
    EH51 0NS Boness
    32
    West Lothian
    United KingdomBritish83466350002
    MITCHELL, David Frank Robert
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    Administrateur
    8 East Claremont Street
    EH7 4JP Edinburgh
    British97869190001
    PECK, David Howard
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    Administrateur
    Muirwood
    Bankrugg
    EH41 4JS Gifford
    East Lothian
    British48939900005
    RIDEHALGH, Jonathan Mark
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Lancashire
    Administrateur
    Burnt House Farm
    Blacko
    BB9 6RG Nelson
    Lancashire
    United KingdomBritish76321080001
    SMITH, Alexander
    17 Cargil Terrace
    EH5 3ND Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    17 Cargil Terrace
    EH5 3ND Edinburgh
    Lothian
    British76129550001
    WOTHERSPOON, Robert John
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Glenlyon House
    Fortingall
    PH15 2LN Aberfeldy
    Perthshire
    ScotlandBritish161858620001
    REYNARD NOMINEES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900011050001
    TM COMPANY SERVICES LIMITED
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur désigné
    Edinburgh Quay
    133 Fountainbridge
    EH3 9AG Edinburgh
    Midlothian
    900003410001

    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 31 mars 2008
    Livré le 09 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground to west of stoneywood papermill, dyce, aberdeen ABN95936.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 13 mars 2008
    Livré le 25 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The area of ground extending to 0.216 hectares or thereby lying to the east of leith street in the city of edinburgh and county of midlothian.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 mars 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 21 janv. 2008
    Livré le 23 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over freehold property known as miller arcade, preston LA552104.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 janv. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 04 oct. 2007
    Livré le 09 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease over 9 longman drive, inverness INV4137.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 04 oct. 2007
    Livré le 09 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in lease over 7 longman drive, inverness INV6983.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7A inshes holdings, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 03 oct. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.92 hectare development site at the inshes holdings, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 08 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    78 and 84-90 glasgow street, dumfries DMF15650.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 mai 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 04 déc. 2006
    Livré le 06 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 7, pentland industrial estate, loanhead MID88399.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 2006
    Livré le 22 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit c, plot 3(known as 5 livingstone boulevard), hamilton international technology park, blantyre.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 1, hareness road, aberdeen KNC4408.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 août 2006
    Livré le 15 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    84/86 prestwick road, ayr AYR52114.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 02 juin 2006
    Livré le 12 juin 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects known as cherrybank, perth.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 juin 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 25 janv. 2006
    Livré le 04 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Unit 2, hamilton road, hallside, cambuslang LAN117711.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 06 déc. 2005
    Livré le 12 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    9 high street, inverness.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 nov. 2005
    Livré le 18 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects at 15-17 high street, dingwall...see mortgage document for full description.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 nov. 2005
    Livré le 12 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    That plot or area of ground in the former royal burgh and parish of dingwall and county of ross and cromarty extending to five hundred and four one thousandth parts of an acre or thereby (see form 410 paper apart for full details).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 14 juin 2005
    Livré le 28 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all the freehold/leasehold property known as brunel gate, aylesbury (title number BM213744).
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 nov. 2004
    Livré le 16 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    7 nettlehill road, livingston, west lothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 sept. 2004
    Livré le 01 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 14 september 2004
    Brèves mentions
    The basement, ground and first floor above ground premises at 15 and 17 frederick street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 14 juil. 2004
    Livré le 22 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 8 july 2004
    Brèves mentions
    The property known as dunedin house, 25 ravelston terrace, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 14 mai 2004
    Livré le 15 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the leasehold property known as phase 1, britannia park, middlesbrough (title number CE132852).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 mai 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 24 mars 2004
    Livré le 01 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over phase 1, britannia park, middlesbrough CE132852.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 2004
    Livré le 18 févr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of a personal bond dated 28 january 2004
    Brèves mentions
    The subjects known as 96 willowbank road, aberdeen...see mortgage document for full description.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 2003
    Livré le 01 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    178, 180,182 & 186 trongate, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    KILMARTIN PROPERTY GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Administrative receiver appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    administrative receiver
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    J B Cartwright
    Erskine House
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    administrative receiver
    Erskine House
    68 - 73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0