CASTLESTREAM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTLESTREAM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC158545
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTLESTREAM LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe CASTLESTREAM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Interpath Ltd
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CASTLESTREAM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTLESTREAM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    7 pagesLIQ13(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 319 st Vincent Street Glasgow G2 5AS à C/O Interpath Ltd 5th Floor 130 st Vincent Street Glasgow G2 5HF le 02 févr. 2022

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Venlaw 349 Bath Street Glasgow G2 4AA Scotland à 319 st Vincent Street Glasgow G2 5AS le 07 oct. 2021

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 17 sept. 2021

    LRESSP

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1585450016 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2019

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Douglas Alexander Cumine en tant que secrétaire le 31 déc. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 30 juin 2019 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2018

    2 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Notification de The Legal Services Centre Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 08 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Notification de Tosca Glasgow Ii Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    1 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Douglas Alexander Cumine en tant que directeur le 20 mars 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CASTLESTREAM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CAMPBELL, Sarah Ann
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    Administrateur
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    ScotlandBritishFinance Director202397690001
    CLAPHAM, Ronald Barrie
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    Administrateur
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    ScotlandBritishDirector101562830001
    MCDONALD, Derek
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    Administrateur
    5th Floor 130 St Vincent Street
    G2 5HF Glasgow
    C/O Interpath Ltd
    ScotlandBritishManaging Director190466700001
    CUMINE, Douglas Alexander
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    Secrétaire
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    BritishChartered Accountant85590510001
    MACROBERTS
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    Secrétaire
    152 Bath Street
    G2 4TB Glasgow
    32443220001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secrétaire
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    CLAPHAM, Mari Alexander
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    Administrateur
    6 Kirklee Terrace
    G12 0TQ Glasgow
    United KingdomBritishCompany Director118413430001
    CUMINE, Douglas Alexander
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    Administrateur
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    ScotlandBritishChartered Accountant85590510001
    PORTER, Derek
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    Administrateur
    349 Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    Venlaw
    Scotland
    United KingdomBritishChartered Accountant47585310001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLESTREAM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Long Acre
    WC2E 9RA London
    90
    England
    06 avr. 2016
    Long Acre
    WC2E 9RA London
    90
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement09834512
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    349
    Scotland
    06 avr. 2016
    Bath Street
    G2 4AA Glasgow
    349
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc96863
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CASTLESTREAM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 avr. 2014
    Livré le 22 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    101 gorbals street, glasgow GLA42590.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juin 2011
    Livré le 22 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects comprising 101 and 105 gorbals street glasgow GLA42590.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 07 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 09 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 avr. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 06 août 2007
    Livré le 09 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest under the lease of 101 and 105 gorbals street, glasgow GLA42590.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 août 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 juil. 2007
    Livré le 31 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 juil. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 juin 2011Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 avr. 2014Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 07 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 avr. 2006
    Livré le 20 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold interest in subjects in southeast side of gorbals street & southwest side of ballater street comprising 101 & 105 gorbals street, glasgow GLA42590.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of rents
    Créé le 31 mars 2006
    Livré le 12 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The rights, titles, benefits, and interests, whether present or future, of the company in and to the rents over the subjects known as legal house, 101 and 105 ballater street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 30 mars 2006
    Livré le 10 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under each of the composite finance documents
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 avr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 25 août 1998
    Livré le 01 sept. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Tenants interest in the lease registered under title no.gla 42590.
    Personnes ayant droit
    • Portman Building Society
    Transactions
    • 01 sept. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 juil. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 17 août 1998
    Livré le 28 août 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Portman Building Society
    Transactions
    • 28 août 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Rental assignation
    Créé le 11 sept. 1995
    Livré le 11 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See ch microfiche.
    Personnes ayant droit
    • Wruttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 11 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 11 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The tenants interest in the head lease of subjects at the corner of gorbals street and ballater street,strathclyde,which lease is registered in the land register for scotland under title no GLA42590.
    Personnes ayant droit
    • Wruttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 11 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 11 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wurttembergische Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    Transactions
    • 11 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 août 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui
    Standard security
    Créé le 31 août 1995
    Livré le 07 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground at the corner of gorbals street and ballater street, glasgow, registered under title number gla 42590.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 29 août 1995
    Livré le 06 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 06 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 sept. 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 mars 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 29 août 1995
    Livré le 05 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 1995Enregistrement d'une charge (410)
    • 28 sept. 1995Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    • Présente des modifications aux interdictions Oui

    CASTLESTREAM LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 févr. 2023Due to be dissolved on
    17 sept. 2021Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0