CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC158880
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CITY INN LIMITED28 sept. 200028 sept. 2000
    FIRST STOP HOTELS LIMITED27 juin 199527 juin 1995

    Quels sont les derniers comptes de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Nomination de Mr Raymond Annel Marquis en tant qu'administrateur le 22 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Emma Jane Morton en tant qu'administrateur le 22 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Panayot Kostadinov Vasilev en tant que directeur le 22 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon David Austin Davies en tant que directeur le 22 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    8 pagesLIQ13(Scot)

    Cessation de la nomination de John Khay-Yan Wong en tant que directeur le 17 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Mr Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018

    2 pagesPSC04

    Notification de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018

    2 pagesPSC01

    Nomination de Mr John Khay-Yan Wong en tant qu'administrateur le 03 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gabriel Petersen en tant que directeur le 03 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2016

    LRESSP

    Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 27 juin 2015

    23 pagesRP04AR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2016

    21 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 août 2016

    État du capital au 16 août 2016

    • Capital: GBP 101,053
    SH01

    Satisfaction de la charge 25 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 27 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1588800029 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 26 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1588800030 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1588800028 en totalité

    1 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 mai 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Mr Panayot Kostadinov Vasilev en tant qu'administrateur le 14 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gabriel Petersen le 16 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon David Austin Davies le 16 avr. 2016

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secrétaire
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement08334728
    175738460001
    MARQUIS, Raymond Annel
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    United KingdomBritish243770520001
    MORTON, Emma Jane
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    Administrateur
    St James' Square
    SW1Y 4LB London
    12
    United Kingdom
    EnglandBritish264422520001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Secrétaire
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    British52526750008
    PAIN, Fennigje
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    Secrétaire
    C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    United Kingdom
    169634590001
    SALMER, Gabriele
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Secrétaire
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    163370600001
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    ANDERSON, Bruce Smith
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    Administrateur
    2 Bramdean View
    EH10 6JX Edinburgh
    ScotlandBritish73849040001
    BRIANCE, Richard Henry
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish16636440001
    CRERAR, William Gunn
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    13 Northumberland Street
    EH3 6LL Edinburgh
    Midlothian
    British17957980002
    CUMMINGS, Peter Joseph
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Glen View
    6 Barloan Crescent
    G82 2AT Dumbarton
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish68241910003
    DAVIES, Simon David Austin
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritish147210490001
    FISKEN, Gillian Claire
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    Administrateur
    North Park Terrace
    EH4 1DP Edinburgh
    6
    British128106370001
    GATELEY, Donald Kenneth
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Administrateur
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritish104442220001
    HEPBURN, Victor Alexander
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    Administrateur
    c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group
    4th Floor
    11 Earl Grey Street
    EH3 9BN Edinburgh
    New Uberior House
    Scotland
    ScotlandBritish161679840001
    HOOD, Lynn Catherine
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish116713060003
    KANDRAC, Martin
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomSlovakian163382910001
    KATZ, Andrew
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomAmerican163382710002
    MACDONALD, Angus Duncan Forbes
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish93989850003
    MACDONALD, Angus Donald Mackintosh
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish43780001
    MANBY, Peter
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish155467670001
    MATTHEWS, Janet
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    Administrateur
    4 Hoskyns Avenue
    Harley Warren
    WR4 0LL Worcester
    Worcestershire
    British53862640001
    MCFARLANE, Pauline Anne
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritish52526750008
    MCKIE, Gordon Robert
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    Administrateur
    c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited
    26 Worple Road
    Wimbledon
    SW19 4EE London
    First Floor Beacon House
    England
    EnglandBritish155757550001
    NORTH, Michael John
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    Administrateur
    The Mill House
    Astwick
    SG5 4BJ Hertfordshire
    British89984500001
    O'CONNOR, Huw
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandBritish74283080002
    ORR, David James Macconnell
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Administrateur
    c/o Burness Llp
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandBritish100937170004
    ORR, James Alexander Macconnell
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish81233650001
    PETERSEN, Gabriel
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBritish132466780002
    SHEARER, David James Buchanan
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    United KingdomBritish161360020001
    SMITH OF GILMOREHILL, Elizabeth Margaret, Baroness Smith Of Gilmorehill
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    ScotlandBritish43044700001
    STARN, William Robert
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    Administrateur
    3rd Floor Princes Exchange
    1 Earl Grey Street
    EH3 9AQ Edinburgh
    EnglandAmerican154007330001
    VASILEV, Panayot Kostadinov
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    United KingdomBulgarian206224490001
    WATSON, Stuart Iain
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    Administrateur
    Citymark
    150 Fountainbridge
    EH3 9PE Edinburgh
    Level 1,
    United Kingdom
    United KingdomBritish126792450001
    WONG, John Khay-Yan
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Administrateur
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    EnglandBritish226216750001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Stephen Allen Schwarzman
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    30 oct. 2018
    345 Park Avenue
    NY 10154
    New York
    The Blackstone Group Lp
    New York
    United States
    Non
    Nationalité: American
    Pays de résidence: United States
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 janv. 2015
    Livré le 27 janv. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Mint hotel (formerly city inn hotel) finnineston quay, glasgow GLA148962.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 27 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2014
    Livré le 24 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land to the west of neville street and land lying to the north canal wharf, leeds. Title numbers WYK842997 and WYK877560. Also all other plots of land listed on schedule 2 of the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 17 déc. 2014
    Livré le 24 déc. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 24 déc. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 22 sept. 2011
    Livré le 05 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Mint hotel (formerly the city inn hotel) finnieston quay glasgow gla 148962.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 05 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement and deed of accession
    Créé le 15 sept. 2011
    Livré le 05 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 05 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 15 sept. 2011
    Livré le 05 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Bank Ag
    Transactions
    • 05 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 22 juil. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 2009
    Livré le 10 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land to west of neville street, leeds WYK877560.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2009
    Livré le 07 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    A lease of flat 107 millbank court, 24 john islip street, london and store room 107.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 26 mars 2008
    Livré le 26 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Granary wharf, leeds WYK843001 WYK842997 including fixed charges and assignment.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 mars 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2007
    Livré le 11 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    All that benefit of the chargors interest in the development agreement and all rights, titles, benefits and interests relating to the development agreement.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 10 janv. 2007
    Livré le 11 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage granary wharf, leeds WYK834117 and WYK651848 WYK724867 including fixed charges.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 31 mars 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 05 janv. 2007
    Livré le 18 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 39 crutched friars, london NGL749312.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 juin 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 22 déc. 2006
    Livré le 09 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The city inn hotel, finnieston quay, glasgow and ground at finnieston quay GLA148962.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Legal charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 19 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat 107, millbank court, 24 john islip street & store room 107, london NGL320667; 25 savage gardens, london LN27259; hotel site, 31 aytoun street, manchester MAN22824; 30 john islip street, london LN96333 NGL795620; the city inn hotel, 1 brunswick square, brindleyplace, birmingham WM729821; land at temple way, bristol BL65802.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 18 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 déc. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Legal charge
    Créé le 07 nov. 2006
    Livré le 09 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Leasehold property known as flat and store room 107, tenth floor, millbank court, 24 john islip street, london NGL320667.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 14 oct. 2005
    Livré le 27 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 déc. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 06 juil. 2005
    Livré le 08 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all that freehold property known as 25 savage gardens, london (title number LN27259); fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 03 juin 2005
    Livré le 08 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due under or in connection with the finance documents
    Brèves mentions
    Legal mortgage over all that leasehold land at piccadilly triangle demised by an underlease between piccadilly place trustee (no.1) limited and piccadilly place trustee (no.2) limited and city inn limited dated 2 june 2005; fixed and floating charges over assets.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 27 mai 2004
    Livré le 09 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Hotel site, piccadilly triangle, manchester.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 avr. 2001
    Livré le 20 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the property (land at john islip street, london); fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 17 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 07 août 2000
    Livré le 10 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 02 août 2000
    Livré le 15 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at finnieston quay, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 19 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 sept. 2016Commencement of winding up
    27 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0