CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC158880 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Nomination de Mr Raymond Annel Marquis en tant qu'administrateur le 22 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Emma Jane Morton en tant qu'administrateur le 22 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Panayot Kostadinov Vasilev en tant que directeur le 22 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon David Austin Davies en tant que directeur le 22 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 8 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Khay-Yan Wong en tant que directeur le 17 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Mr Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018 | 2 pages | PSC04 | ||||||||||
Notification de Stephen Allen Schwarzman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 oct. 2018 | 2 pages | PSC01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Khay-Yan Wong en tant qu'administrateur le 03 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gabriel Petersen en tant que directeur le 03 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Deuxième dépôt du bilan annuel arrêté au 27 juin 2015 | 23 pages | RP04AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2016 | 21 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 25 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 27 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1588800029 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 26 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1588800030 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC1588800028 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Panayot Kostadinov Vasilev en tant qu'administrateur le 14 avr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Gabriel Petersen le 16 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon David Austin Davies le 16 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED | Secrétaire | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England |
| 175738460001 | ||||||||||
| MARQUIS, Raymond Annel | Administrateur | St James' Square SW1Y 4LB London 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 243770520001 | |||||||||
| MORTON, Emma Jane | Administrateur | St James' Square SW1Y 4LB London 12 United Kingdom | England | British | 264422520001 | |||||||||
| MCFARLANE, Pauline Anne | Secrétaire | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | British | 52526750008 | ||||||||||
| PAIN, Fennigje | Secrétaire | C/O Axios Hospitality Real Estate Services Limited 26 Worple Road Wimbledon SW19 4EE London First Floor Beacon House United Kingdom | 169634590001 | |||||||||||
| SALMER, Gabriele | Secrétaire | c/o Burness Llp Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | 163370600001 | |||||||||||
| ORR MACQUEEN WS | Secrétaire désigné | 36 Heriot Row EH3 6ES Edinburgh | 900000160001 | |||||||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Administrateur | 2 Bramdean View EH10 6JX Edinburgh | Scotland | British | 73849040001 | |||||||||
| BRIANCE, Richard Henry | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | England | British | 16636440001 | |||||||||
| CRERAR, William Gunn | Administrateur | 13 Northumberland Street EH3 6LL Edinburgh Midlothian | British | 17957980002 | ||||||||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Administrateur | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||||||
| DAVIES, Simon David Austin | Administrateur | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England | United Kingdom | British | 147210490001 | |||||||||
| FISKEN, Gillian Claire | Administrateur | North Park Terrace EH4 1DP Edinburgh 6 | British | 128106370001 | ||||||||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Administrateur | Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Level 1, United Kingdom | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||||||
| HEPBURN, Victor Alexander | Administrateur | c/o Joint Ventures Equity, Lloyds Banking Group 4th Floor 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh New Uberior House Scotland | Scotland | British | 161679840001 | |||||||||
| HOOD, Lynn Catherine | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | Scotland | British | 116713060003 | |||||||||
| KANDRAC, Martin | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | Slovakian | 163382910001 | |||||||||
| KATZ, Andrew | Administrateur | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | United Kingdom | American | 163382710002 | |||||||||
| MACDONALD, Angus Duncan Forbes | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | England | British | 93989850003 | |||||||||
| MACDONALD, Angus Donald Mackintosh | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | Scotland | British | 43780001 | |||||||||
| MANBY, Peter | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | England | British | 155467670001 | |||||||||
| MATTHEWS, Janet | Administrateur | 4 Hoskyns Avenue Harley Warren WR4 0LL Worcester Worcestershire | British | 53862640001 | ||||||||||
| MCFARLANE, Pauline Anne | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | United Kingdom | British | 52526750008 | |||||||||
| MCKIE, Gordon Robert | Administrateur | c/o Axios Hospitality Real Estate Services Limited 26 Worple Road Wimbledon SW19 4EE London First Floor Beacon House England | England | British | 155757550001 | |||||||||
| NORTH, Michael John | Administrateur | The Mill House Astwick SG5 4BJ Hertfordshire | British | 89984500001 | ||||||||||
| O'CONNOR, Huw | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | England | British | 74283080002 | |||||||||
| ORR, David James Macconnell | Administrateur | c/o Burness Llp Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland | England | British | 100937170004 | |||||||||
| ORR, James Alexander Macconnell | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | Scotland | British | 81233650001 | |||||||||
| PETERSEN, Gabriel | Administrateur | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England | United Kingdom | British | 132466780002 | |||||||||
| SHEARER, David James Buchanan | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | United Kingdom | British | 161360020001 | |||||||||
| SMITH OF GILMOREHILL, Elizabeth Margaret, Baroness Smith Of Gilmorehill | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | Scotland | British | 43044700001 | |||||||||
| STARN, William Robert | Administrateur | 3rd Floor Princes Exchange 1 Earl Grey Street EH3 9AQ Edinburgh | England | American | 154007330001 | |||||||||
| VASILEV, Panayot Kostadinov | Administrateur | 21 Palmer Street SW1H 0AD London Asticus Building 2nd Floor England | United Kingdom | Bulgarian | 206224490001 | |||||||||
| WATSON, Stuart Iain | Administrateur | Citymark 150 Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh Level 1, United Kingdom | United Kingdom | British | 126792450001 | |||||||||
| WONG, John Khay-Yan | Administrateur | Berkeley Square W1J 5AL London 40 England | England | British | 226216750001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 30 oct. 2018 | 345 Park Avenue NY 10154 New York The Blackstone Group Lp New York United States | Non |
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||
Nature du contrôle
| |||
CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 14 janv. 2015 Livré le 27 janv. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Mint hotel (formerly city inn hotel) finnineston quay, glasgow GLA148962. Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2014 Livré le 24 déc. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land to the west of neville street and land lying to the north canal wharf, leeds. Title numbers WYK842997 and WYK877560. Also all other plots of land listed on schedule 2 of the instrument. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 17 déc. 2014 Livré le 24 déc. 2014 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 22 sept. 2011 Livré le 05 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Mint hotel (formerly the city inn hotel) finnieston quay glasgow gla 148962. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Security agreement and deed of accession | Créé le 15 sept. 2011 Livré le 05 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 15 sept. 2011 Livré le 05 oct. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 déc. 2009 Livré le 10 déc. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Land to west of neville street, leeds WYK877560. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 19 juin 2009 Livré le 07 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions A lease of flat 107 millbank court, 24 john islip street, london and store room 107. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 26 mars 2008 Livré le 26 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Granary wharf, leeds WYK843001 WYK842997 including fixed charges and assignment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 10 janv. 2007 Livré le 11 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions All that benefit of the chargors interest in the development agreement and all rights, titles, benefits and interests relating to the development agreement. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 10 janv. 2007 Livré le 11 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions By way of legal mortgage granary wharf, leeds WYK834117 and WYK651848 WYK724867 including fixed charges. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 05 janv. 2007 Livré le 18 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over 39 crutched friars, london NGL749312. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 22 déc. 2006 Livré le 09 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The city inn hotel, finnieston quay, glasgow and ground at finnieston quay GLA148962. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 08 déc. 2006 Livré le 19 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Flat 107, millbank court, 24 john islip street & store room 107, london NGL320667; 25 savage gardens, london LN27259; hotel site, 31 aytoun street, manchester MAN22824; 30 john islip street, london LN96333 NGL795620; the city inn hotel, 1 brunswick square, brindleyplace, birmingham WM729821; land at temple way, bristol BL65802. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 08 déc. 2006 Livré le 18 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 07 nov. 2006 Livré le 09 nov. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Leasehold property known as flat and store room 107, tenth floor, millbank court, 24 john islip street, london NGL320667. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 14 oct. 2005 Livré le 27 oct. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
| Floating charge | Créé le 06 juil. 2005 Livré le 08 juil. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions Legal mortgage over all that freehold property known as 25 savage gardens, london (title number LN27259); fixed and floating charges over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 03 juin 2005 Livré le 08 juin 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due under or in connection with the finance documents | |
Brèves mentions Legal mortgage over all that leasehold land at piccadilly triangle demised by an underlease between piccadilly place trustee (no.1) limited and piccadilly place trustee (no.2) limited and city inn limited dated 2 june 2005; fixed and floating charges over assets. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 27 mai 2004 Livré le 09 juin 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Hotel site, piccadilly triangle, manchester. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Floating charge | Créé le 18 avr. 2001 Livré le 20 avr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over the property (land at john islip street, london); fixed charges over assets; floating charge over same. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 17 août 2000 Livré le 01 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 17 août 2000 Livré le 01 sept. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 07 août 2000 Livré le 10 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Standard security | Créé le 02 août 2000 Livré le 15 août 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Ground at finnieston quay, glasgow. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CAROLIA HOSPITALITY UK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0