THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED

THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC160106
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Installation de plomberie, de chauffage et de climatisation (43220) / Construction

    Où se situe THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite 2-3, Titan Enterprise Business Centre
    1 Aurora Avenue Queens Quay
    G81 1BF Clydebank
    Dumbartonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Jack Rainer Ullmann en tant que directeur le 12 mars 2021

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de PO Box 24072 Sc160106: Companies House Default Address Edinburgh EH3 1FD à Suite 2-3, Titan Enterprise Business Centre 1 Aurora Avenue Queens Quay Clydebank Dumbartonshire G81 1BF le 18 mars 2021

    1 pagesAD01

    Adresse du siège social modifiée à PO Box 24072, Sc160106: Companies House Default Address, Edinburgh, EH3 1FD le 22 janv. 2021

    1 pagesRP05

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de Darren Abernethy en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mars 2020

    1 pagesPSC07

    Satisfaction de la charge SC1601060007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1601060002 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1601060003 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1601060006 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 16 mars 2020

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge SC1601060005 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge SC1601060004 en totalité

    1 pagesMR04

    Nomination de Mr Chris Martin Kenneally en tant qu'administrateur le 05 mars 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Chris Martin Kenneally en tant que directeur le 05 mars 2020

    1 pagesTM01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modifications à la charge flottante SC1601060004

    71 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1601060006

    71 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1601060005

    71 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1601060007

    71 pages466(Scot)

    Qui sont les dirigeants de THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ULLMANN, Phillip Lionel
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    EnglandBritishDirector46458480002
    ABERNETHY, Darren
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Secrétaire
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    British115068670001
    MILLER, David Martin
    51 Woburn Drive
    Hale
    WA15 8ND Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    51 Woburn Drive
    Hale
    WA15 8ND Altrincham
    Cheshire
    British41627070001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Secrétaire désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    ABERNETHY, Darren
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    ScotlandBritishDirector115068670001
    ABERNETHY, Duncan
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    United KingdomBritishDirector44510300001
    GAY, John
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    United KingdomBritishDirector19175800009
    GRAY, John Hodge
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    United KingdomBritishOperations Director75815540002
    KENNEALLY, Chris Martin
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    WalesBritishCompany Director267876240001
    KENNEALLY, Chris Martin
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    WalesBritishDirector267876240001
    ULLMANN, Jack Rainer
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    Administrateur
    100e Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Chryston
    Glasgow
    EnglandBritishDirector11342820001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Administrateur désigné
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Darren Abernethy
    Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Glasgow
    100e
    Scotland
    06 avr. 2016
    Cumbernauld Road
    Muirhead
    G69 9AB Glasgow
    100e
    Scotland
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Ukfm Group Limited
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    06 avr. 2016
    Long Lane
    Hillingdon
    UB10 9PF Uxbridge
    Chevron House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementUk Companies Houe
    Numéro d'enregistrement03560415
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    THERMOTECH ENGINEERING SERVICES (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 15 août 2016
    Livré le 15 août 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Centrovalli LTD
    Transactions
    • 15 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 31 mai 2016
    Livré le 07 juin 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed and floating charges over all the assets and undertaking of the company, present and future, as more particularly described in clause 3 of the guarantee and fixed and floating charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed and floating charge over all of the assets. See deed for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 19 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 22 juin 2015Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 12 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Fixed and floating charge over all of the assets. See deed for further details.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 12 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 juin 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 nov. 2016Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juil. 2017Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 janv. 2018Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 juil. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    A registered charge
    Créé le 09 août 2013
    Livré le 12 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0