BUILDSTORE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBUILDSTORE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC164555
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BUILDSTORE LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe BUILDSTORE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BUILDSTORE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SELF BUILD ADVISORY SERVICE LIMITED19 févr. 199719 févr. 1997
    TELEWILLS LIMITED08 mai 199608 mai 1996
    FLOPPYFLANK LIMITED29 mars 199629 mars 1996

    Quels sont les derniers comptes de BUILDSTORE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour BUILDSTORE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    11 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    2 pages2.22B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Kingsthorne Park Houstoun Industrial Estate Livingston West Lothian EH54 5DB le 25 oct. 2010

    2 pagesAD01

    legacy

    3 pagesMG03s

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    Avis d'insuffisance d'actifs pour la distribution aux créanciers non garantis autres qu'en vertu de l'article S176A(2)(A)

    1 pages2.32B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    47 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.13B(Scot)

    24 pages2.15B(Scot)

    État du capital après une attribution d'actions au 13 nov. 2008

    • Capital: GBP 339,296
    4 pagesSH01

    Modifications à la charge flottante 2

    11 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 3

    11 pages466(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.11B(Scot)

    legacy

    23 pages363a

    legacy

    2 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04

    Modifications à la charge flottante 2

    8 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 3

    8 pages466(Scot)

    legacy

    2 pages88(2)

    Qui sont les dirigeants de BUILDSTORE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARSHALL, David
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    Secrétaire
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    British79453940001
    CONNOR, Raymond Thomas
    St Swithin's Cottage
    EH26 9LZ Ninemileburn
    Midlothian
    Administrateur
    St Swithin's Cottage
    EH26 9LZ Ninemileburn
    Midlothian
    ScotlandBritish362260001
    DOHERTY, Timothy Patrick Lee
    Windmill Farm Cottage
    Benhall Mill Road
    TN2 5JW Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    Windmill Farm Cottage
    Benhall Mill Road
    TN2 5JW Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish46218940002
    FEE, Nigel Terry
    Lomond House
    35 Bathwick Hill
    BA2 6LD Bath
    Administrateur
    Lomond House
    35 Bathwick Hill
    BA2 6LD Bath
    United KingdomBritish83070690001
    MADDRELL, Geoffrey Keggen
    28 Sussex Street
    SW1V 4RL London
    Administrateur
    28 Sussex Street
    SW1V 4RL London
    United KingdomBritish17150180001
    MARSHALL, David
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    Administrateur
    5 Kelvin Crescent
    Bearsden
    G61 1BT Glasgow
    United KingdomBritish79453940001
    BATTY, David Stewart
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    Secrétaire
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    British25024920003
    FOLEY, John Gerard
    2 Bradda Avenue
    Burnside
    G73 5DE Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    2 Bradda Avenue
    Burnside
    G73 5DE Glasgow
    Lanarkshire
    British89596720001
    HUGHES, John Gillies
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    British70285020002
    MALCOLM, Connor
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    British478200001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BATTY, David Stewart
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    Administrateur
    10 Bowling Green Road
    EH29 9BG Kirkliston
    West Lothian
    United KingdomBritish25024920003
    COVEY, Victor George Christopher
    31 Duddingston Park
    EH15 1JU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    31 Duddingston Park
    EH15 1JU Edinburgh
    Midlothian
    British239600004
    FOLEY, John Gerard
    2 Bradda Avenue
    Burnside
    G73 5DE Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    2 Bradda Avenue
    Burnside
    G73 5DE Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish89596720001
    HAY, John Mcgregor
    44 Blinkbonny Road
    EH4 3HX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    44 Blinkbonny Road
    EH4 3HX Edinburgh
    Lothian
    British77251830001
    HUGHES, John Gillies
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 Inverleith Terrace
    EH3 5NS Edinburgh
    Midlothian
    British70285020002
    HUTCHINSON, Steve Richard
    3 The Manor
    SG19 2RN Potton
    Bedfordshire
    Administrateur
    3 The Manor
    SG19 2RN Potton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish6051250001
    MALCOLM, William Fraser
    40 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    40 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38133820001
    NEILLY, Gordon Joseph
    5 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    Administrateur
    5 Newlands
    EH27 8LR Kirknewton
    Midlothian
    ScotlandBritish56349450002
    WALTON, Roger Victor
    8 Oakdene
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    8 Oakdene
    HP9 2BZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British45958030001
    WILLIAMSON, Peter James, Dr.
    Flat 1 27 Hyde Park Gardens
    W2 2LZ London
    Administrateur
    Flat 1 27 Hyde Park Gardens
    W2 2LZ London
    British66604440001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    BUILDSTORE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 14 août 2008
    Livré le 27 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over land adjoining river house, porters hatch, meare, somerset WS39589.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 août 2008Enregistrement d'une charge (410)
    Legal charge
    Créé le 17 juil. 2006
    Livré le 02 août 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over UNIT1, lydiard fields, lydiard tregoze, swindon, wiltshire WT238337.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 2006Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 22 juin 2005
    Livré le 29 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Skipton Building Society
    Transactions
    • 29 juin 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 12 juil. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 20 oct. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 avr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 30 mars 2005
    Livré le 30 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 juil. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 oct. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 10 avr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 03 déc. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 1999
    Livré le 01 févr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Tsb Bank Scotland PLC
    Transactions
    • 01 févr. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    BUILDSTORE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 nov. 2012Administration ended
    20 nov. 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David J Hill
    Bdo Llp 4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    practitioner
    Bdo Llp 4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    James B Stephen
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow
    practitioner
    4 Atlantic Quay
    70 York Street
    G2 8JX Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0