TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED

TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC164651
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    106 Main Street
    Coatbridge
    ML5 3EL North Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2010

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 mars 2010 sans liste des membres

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de John Rennie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Helen Mckenna en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Stewart Jamieson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Assets transfer 19/03/2010
    RES13

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2009

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2007

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2006

    6 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(288)

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2005

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de TOWN CENTRE INITIATIVES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALKER, Emma Jane
    48 Cherry Avenue
    Abronhill
    G67 3BG Cumbernauld
    Lanarkshire
    Secrétaire
    48 Cherry Avenue
    Abronhill
    G67 3BG Cumbernauld
    Lanarkshire
    British116854770001
    MAGINNIS, Thomas, Councillor
    2 Dunnachie Drive
    ML5 5SB Coatbridge
    North Lanarkshire
    Administrateur
    2 Dunnachie Drive
    ML5 5SB Coatbridge
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish65693150001
    MCCONACHIE, Maureen Alexandra
    16 Carronlea Drive
    FK2 8DN Falkirk
    Stirlingshire
    Administrateur
    16 Carronlea Drive
    FK2 8DN Falkirk
    Stirlingshire
    ScotlandBritish68544630001
    ORMEROD, Christopher John
    3 Linnvale Way
    Dullatur
    G68 0FG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Linnvale Way
    Dullatur
    G68 0FG Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish505830004
    REILLY, John
    66 Coltswood Road
    ML5 2AA Coatbridge
    North Lanarkshire
    Administrateur
    66 Coltswood Road
    ML5 2AA Coatbridge
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish58717000001
    HALPIN, John
    15 Elsinore Path
    East Kilbride
    G75 0DT Glasgow
    Secrétaire
    15 Elsinore Path
    East Kilbride
    G75 0DT Glasgow
    British55483730001
    JAMIESON, Stewart
    23 Wilsons Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Motherwell
    Secrétaire
    23 Wilsons Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Motherwell
    British111869560001
    LANDERY, Frederick Alexander
    45 Sycamore Drive
    ML3 7HF Hamilton
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    45 Sycamore Drive
    ML3 7HF Hamilton
    Lanarkshire
    Scotland
    British48427790001
    BRODIES WS
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Secrétaire désigné
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    900000290001
    BLYTH, Catriona
    43 Kenilworth Crescent
    ML4 3EQ Bellshill
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    43 Kenilworth Crescent
    ML4 3EQ Bellshill
    Lanarkshire
    Scotland
    British50207930001
    CLYDE, Anne
    54a Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    Administrateur
    54a Station Road
    ML8 5AD Carluke
    Lanarkshire
    United KingdomBritish48902630001
    CURRAN, Harry
    8 Glenfinnan Grove
    ML4 2AY Bellshill
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Glenfinnan Grove
    ML4 2AY Bellshill
    Lanarkshire
    ScotlandScottish48153080002
    FACHIE, William
    3 Strathclyde View
    G71 8NJ Bothwell
    Administrateur
    3 Strathclyde View
    G71 8NJ Bothwell
    United KingdomBritish80312050001
    JAMIESON, Stewart
    23 Wilsons Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Motherwell
    Administrateur
    23 Wilsons Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Motherwell
    British111869560001
    LAWSON, Ian Grahame
    22 Buchanan Street
    Milngavie
    G62 8AN Glasgow
    Administrateur
    22 Buchanan Street
    Milngavie
    G62 8AN Glasgow
    British48902550001
    MALLOY, Ann
    The Dovecot Blackwood Estate
    ML11 0JG Blackwood
    South Lanarkshire
    Administrateur
    The Dovecot Blackwood Estate
    ML11 0JG Blackwood
    South Lanarkshire
    British75956800001
    MCAULEY, Caitriona
    2l 18 Norham Street
    Shawlands
    G41 3XQ Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    2l 18 Norham Street
    Shawlands
    G41 3XQ Glasgow
    Strathclyde
    British47080390001
    MCKENNA, Helen, Councillor
    14 Aberlour Place
    Carfin
    ML1 4FX Motherwell
    Lanarkshire
    Administrateur
    14 Aberlour Place
    Carfin
    ML1 4FX Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish103757710001
    MORTON, Gail
    Flat 3/1 76 Thornwood Drive
    Broomhill
    G11 7PR Glasgow
    Scotland
    Administrateur
    Flat 3/1 76 Thornwood Drive
    Broomhill
    G11 7PR Glasgow
    Scotland
    British50207980001
    PORCH, David Moore
    27 Inch Marnock
    G74 2JQ East Kilbride
    Administrateur
    27 Inch Marnock
    G74 2JQ East Kilbride
    British59551890001
    RENNIE, John Anthony
    Dykehead Farm
    Kilsyth
    G65 9LG Glasgow
    Administrateur
    Dykehead Farm
    Kilsyth
    G65 9LG Glasgow
    British51049530001
    SMITH, Gordon
    25 Meadowhouse Road
    EH12 7HW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    25 Meadowhouse Road
    EH12 7HW Edinburgh
    Midlothian
    British646310002
    STEPHENSON, David Charles
    1 Barnton Gardens
    EH4 6AF Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    1 Barnton Gardens
    EH4 6AF Edinburgh
    Lothian
    British45709980002
    STITT, Catherine
    6a Wilson's Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Lanarkshire
    Administrateur
    6a Wilson's Road
    Hareshaw
    ML1 5NA Cleland
    Lanarkshire
    United KingdomBritish121784140001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0