NCM FUND SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNCM FUND SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC166074
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fourth Floor, 7
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NCM FINANCE LIMITED12 nov. 200912 nov. 2009
    NOBLE CORPORATE MANAGEMENT LIMITED22 déc. 200522 déc. 2005
    NOBLE PARTNERSHIP LIMITED30 sept. 199630 sept. 1996
    DUNWILCO (512) LIMITED04 juin 199604 juin 1996

    Quels sont les derniers comptes de NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 nov. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 août 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au26 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation09 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au26 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2024

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 26 mars 2024

    3 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 26 mars 2022

    3 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 26 mars 2023

    3 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 26 mars 2021

    3 pagesRP04CS01

    État du capital au 13 mars 2025

    • Capital: GBP 20,000
    3 pagesSH19

    État du capital au 13 mars 2025

    • Capital: GBP 20,000
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amound standing to the credit of the capital redemption reserve be cancelled 12/03/2025
    RES13

    Changement d'adresse du siège social de Fourth Floor Castle Street Edinburgh EH2 3AH Scotland à Fourth Floor, 7 Castle Street Edinburgh EH2 3AH le 19 févr. 2025

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 4th Floor, 7 Castle Street, Edinburgh Castle Street Edinburgh EH2 3AH Scotland à Fourth Floor Castle Street Edinburgh EH2 3AH le 27 janv. 2025

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 26 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    17 mars 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2023

    20 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2022

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    17 mars 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Déclaration de confirmation établie le 26 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    17 mars 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2021

    22 pagesAA

    Modification des détails de Chaplin Finance Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 nov. 2021

    2 pagesPSC05

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Error in submission of SH01 22/03/2021
    RES13

    Déclaration de confirmation établie le 26 mars 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01
    Annotations
    DateAnnotation
    17 mars 2025Second Filing The information on the form CS01 has been replaced by a second filing on 17/03/2025.

    État du capital après une attribution d'actions au 11 mars 2021

    • Capital: GBP 107.53
    3 pagesSH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2020

    16 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 09 janv. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MCLEAY, Kathleen Moir
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Secrétaire
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    149052720001
    CHAPLIN, Robert Henry Moffett
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    United KingdomBritish63131640001
    GRAHAM, Douglas
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    ScotlandBritish162769630001
    MCLEAY, Kathleen Moir
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    ScotlandBritish146173660001
    SULLIVAN, James Alistair
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    Administrateur
    Castle Street
    EH2 3AH Edinburgh
    Fourth Floor, 7
    Scotland
    United KingdomBritish126441710003
    CHURCHILL, Stephen
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    Secrétaire
    13 (1f) Royal Terrace
    EH7 5AB Edinburgh
    British85739530002
    PAGE, Louise
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    Secrétaire
    2/2 Grosvenor Gardens
    EH5 5JU Edinburgh
    British59177160003
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire désigné
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    900004640001
    NOBLE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    Secrétaire
    76 George Street
    EH2 3BU Edinburgh
    94907480001
    ASHTON, Charles James
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Administrateur
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    United KingdomBritish139012420002
    COUTTS, Maureen Sheila
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004630001
    DONALDSON, David Graham
    Newmills House
    1 Newmills Road
    EH14 5AG Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    Newmills House
    1 Newmills Road
    EH14 5AG Balerno
    Midlothian
    ScotlandBritish1077140001
    GRANT, Adam Douglas Mortimer
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    Administrateur
    27 Warwicks Bench
    GU1 3TF Guildford
    Surrey
    EnglandBritish147687150001
    GRAVES, Adrian George
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Matching
    CM17 0QZ Harlow
    Essex
    EnglandUnited Kingdom36906810001
    HARDIE, David
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Administrateur désigné
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    British900004620001
    JESSOP, Alan Dixon
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    Administrateur
    73 Cricketers Lane
    Brentwood
    CM13 3QB Essex
    British67849380002
    MACPHERSON, Angus Robert
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    Administrateur
    76 George Street
    Edinburgh
    EH2 3BU
    ScotlandBritish117526370001
    NASH, Ian Eric
    Mount Cottage
    Linden Chase
    TN13 3JT Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Mount Cottage
    Linden Chase
    TN13 3JT Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish11953390004
    NEWALL, Archibald Patrick
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    Administrateur
    Langton House
    Finch Lane
    HP7 9LU Amersham
    Bucks
    British70430050001
    NOBLE, Timothy Peter, Sir
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    Administrateur
    Ardnahane
    Barnton Avenue
    EH4 6JJ Edinburgh
    United KingdomBritish685750001
    PAGE, David Keith
    14b Drumsheugh Gardens
    EH3 7QG Edinburgh
    Administrateur
    14b Drumsheugh Gardens
    EH3 7QG Edinburgh
    British84309420003
    PHILIPSZ, Joseph Eugene
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    3 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish,Irish83107910002
    POKORA, David Bernard
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    Administrateur
    30 Pitchens End
    SN4 9PR Broad Hinton
    Wiltshire
    United KingdomBritish63190500001
    SMEATON, Robin Campbell
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Hillpark Avenue
    EH4 7AT Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandScottish2584040001
    SPEARMAN, Alexander Lochain
    Glenshochie
    PH1 4PX Stanley
    Perthshire
    Administrateur
    Glenshochie
    PH1 4PX Stanley
    Perthshire
    British17991890002
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003
    THOMSON, Benjamin John Paget
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    10 Belford Terrace
    EH4 3DQ Edinburgh
    Midlothian
    British44243290003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur NCM FUND SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Chaplin Finance Limited
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    06 avr. 2016
    Melville Crescent
    EH3 7JA Edinburgh
    7
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0