COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC167176 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Edinburgh House 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 août 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2024 | 9 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Christopher Pears en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr George Richard Trevaskis en tant qu'administrateur le 28 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2023 | 9 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Llewellyn Kevan Botha en tant que secrétaire le 25 janv. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 21 juil. 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Llewellyn Kevan Botha le 10 juil. 2023 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2022 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2022 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Pears le 22 avr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Llewellyn Kevan Botha le 06 avr. 2022 | 1 pages | CH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Llewellyn Kevan Botha le 06 avr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2021 | 9 pages | AA | ||
Nomination de Judith Mary Matthews en tant que secrétaire le 01 déc. 2021 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Jonathan Dolbear en tant que secrétaire le 23 juil. 2021 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2020 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2019 | 9 pages | AA | ||
Nomination de Leighton Peter Hazell-Smart en tant qu'administrateur le 31 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Nazir Sarkar en tant que directeur le 31 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de James Terence Hood en tant que directeur le 31 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Christopher Pears en tant qu'administrateur le 31 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATTHEWS, Judith Mary | Secrétaire | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | 290286880001 | |||||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | South African | 105560560002 | |||||
| HAZELL-SMART, Leighton Peter | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 261140830001 | |||||
| TREVASKIS, George Richard | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 327174080002 | |||||
| BOTHA, Llewellyn Kevan | Secrétaire | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | South African | 105560560001 | ||||||
| CORNEY, Darryl John | Secrétaire | Highcroft Milton Clevedon BA4 6NS Shepton Mallet Somerset | British | 83564940010 | ||||||
| DOLBEAR, Jonathan | Secrétaire | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | 161908660001 | |||||||
| MACGILLIVRAY, Shirley Margaret | Secrétaire | 52 Erskine Road EH52 6XL Broxburn West Lothian | British | 40027890001 | ||||||
| WALLACE, Barbara Charlotte | Secrétaire | 180 Springfield Road EH49 7JT Linlithgow West Lothian | British | 59091840002 | ||||||
| BRAASCH, Jochen | Administrateur | Woodfield Road Redland BS6 6PL Bristol Apt Number 15, Chandos England | England | German | 153472260001 | |||||
| CAMPBELL, Hew | Administrateur | 44 Castleknowe Gardens Kirkton Park ML8 5UX Carluke Scotland | British | 1416100007 | ||||||
| CROSBY, William Stuart | Administrateur | 705 Tead Froad Shad Thames SE1 2AS London | Australian | 108743530001 | ||||||
| GILCHRIST, David John | Administrateur | 1 Hollybank Place East Calder EH53 0QW Livingston West Lothian | British | 51330970001 | ||||||
| HOOD, James Terence | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | Wales | British | 189833420002 | |||||
| HOOD, James Terence | Administrateur | Redland Road BS6 6YA Bristol 140b Avon United Kingdom | England | British | 189833420001 | |||||
| HUDD, David John | Administrateur | 2 The Barton Hanham BS15 3LW Bristol Avon | England | British | 84292790001 | |||||
| MCKEAN, Alan Wallace | Administrateur | 141 Colinton Road EH14 1BG Edinburgh | British | 1019950002 | ||||||
| MILLS, Christopher Andrew | Administrateur | Park Lane, Blagdon BS40 7SB Bristol Heronmere England | England | British | 178211930001 | |||||
| MORRIS, Christopher John | Administrateur | 123 Beaconsfield Parade 3206 Albert Park Unit 10 Australia | Australia | Australian | 167662610001 | |||||
| MORRISON, Thomas Vance | Administrateur | 17 East Barnton Gardens EH4 6AR Edinburgh | British | 1024220002 | ||||||
| OLDFIELD, Nicholas Stuart Robert | Administrateur | Limeburn Hill Chew Magna BS40 8QR Bristol Greenleigh Farm Holt United Kingdom | United Kingdom | British | 116701010002 | |||||
| OWEN, John William | Administrateur | Little Green Cottage Little Green Easton BA5 1AU Wells Somerset | England | British | 59069620001 | |||||
| PEARS, Christopher | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | England | British | 261112330002 | |||||
| SARKAR, Nazir | Administrateur | 4 North St. Andrew Street EH2 1HJ Edinburgh Edinburgh House Scotland | United States | British | 157131040016 | |||||
| SARLING, Barry Eric | Administrateur | 1 Springfield Road Portishead BS20 9LH Bristol | British | 52848370001 | ||||||
| SMITH, Jason Leigh | Administrateur | 2 Providence Lane Long Ashton BS41 9DG Bristol | Australian | 115310950001 | ||||||
| STEWART, Colin Ross | Administrateur | 66 Cammo Grove EH4 8HA Edinburgh Midlothian | British | 360200001 | ||||||
| STOCKDALE, Edward John | Administrateur | Rock Villa, 18 Dundry Lane Winford BS40 8AW Bristol Avon | British | 65838060002 | ||||||
| TOUGH, Eric George William | Administrateur | 4 Doune Terrace EH3 6DY Edinburgh | British | 54132470001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPUTERSHARE SERVICES NOMINEES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Computershare Investor Services Plc | 08 avr. 2016 | Bridgwater Road BS13 8AE Bristol The Pavilions England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0