CENTROS MILLER 1999 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CENTROS MILLER 1999 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC168068 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CENTROS MILLER 1999 LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CENTROS MILLER 1999 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour CENTROS MILLER 1999 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché) | 14 pages | LIQ13(Scot) | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL à C/O Mazars Llp Apex 2 97 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD le 10 oct. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Paul Jonathan Goswell en tant qu'administrateur le 05 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew Sutherland en tant qu'administrateur le 05 sept. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Miller House 2 Lochside View Edinburgh Park Edinburgh EH12 9DH à 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL le 25 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 14 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Euan James Edward Haggerty en tant que directeur le 30 juin 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 11 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Hartley Miller en tant que directeur le 31 mai 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 12 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Frederic Hewett en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 13 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CENTROS MILLER 1999 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOSWELL, Paul Jonathan | Administrateur | 3 Scarth Road Barnes SW13 0ND London Westcott House United Kingdom | England | British | 202597650001 | |||||
| HADEN-SCOTT, Timothy | Administrateur | Lansdowne House Berkeley Square W1J 6ER London Delancey 6th Floor United Kingdom | England | British | 133382310002 | |||||
| MILLOY, David Thomas | Administrateur | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | Scotland | British | 76474600001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Administrateur | Apex 2 97 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh C/O Mazars Llp | United Kingdom | British | 66368290003 | |||||
| DONALDSON, Euan James | Secrétaire | Woodburn Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 41273760001 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Secrétaire | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | British | 65057960002 | ||||||
| DM COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh Midlothian | 900000320001 | |||||||
| ANDERSON, Philip Edward | Administrateur | 13 The Priory RH9 8NL Godstone Surrey | British | 14687720001 | ||||||
| BORLAND, Donald William | Administrateur | 408 Ferry Road EH5 2AD Edinburgh | United Kingdom | British | 66010670002 | |||||
| BRUCE, Roderick Lawrence | Administrateur désigné | Rosehill 23 Inveresk Village Inveresk East Lothian | British | 900003110001 | ||||||
| FROST, Simon | Administrateur | 32 Sidney Road KT12 2LZ Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | 16522420002 | |||||
| HAGGERTY, Euan James Edward | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 162679260001 | |||||
| HAMPSON, Lester Paul | Administrateur | 21 Brassey Hill RH8 0ES Oxted Surrey | British | 97665250001 | ||||||
| HARRIS, Nicholas John | Administrateur | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | 74890900001 | |||||
| HARRIS, Nicholas John | Administrateur | Evenlode,248 Station Road B93 0ES Knowle West Midlands | United Kingdom | British | 74890900001 | |||||
| HEWETT, Frederic Mark | Administrateur | 16 The Drive TN9 2LP Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 52840680001 | |||||
| JACKSON, Julie Mansfield | Administrateur | 31 Inverleith Gardens EH3 5PR Edinburgh | United Kingdom | British | 94193070001 | |||||
| LAKER, John Frederick | Administrateur | 57 Greenways KT10 0QH Hinchley Woods Surrey | United Kingdom | British | 54651510001 | |||||
| MARSH, John Charles | Administrateur | 115 Upper Grosvenor Road TN1 2EA Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 85346010001 | |||||
| MILLER, Philip Hartley | Administrateur | Miller House 2 Lochside View EH12 9DH Edinburgh Park Edinburgh | Scotland | British | 28512070005 | |||||
| MINTO, Bruce Watson | Administrateur désigné | 1 Wester Coates Road EH12 5LU Edinburgh | British | 900000330001 | ||||||
| O'REILLY-NEENAN, Marie Bernadette | Administrateur | Ballymulcashel Kilmurry Sixmilebridge Ballymul House Ennis Co Clare Ireland | Irish | 135305100001 | ||||||
| ROBINSON, David | Administrateur | 118 Meadowspot EH10 5UY Edinburgh Lothian | Scotland | United Kingdom | 50541770001 | |||||
| SUTHERLAND, Andrew | Administrateur | 87 Whitehouse Road EH4 6PB Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | 66368290001 | |||||
| WHEELER, John Allan Campbell | Administrateur | 23 South Square NW11 7AJ London | United Kingdom | British | 7882570001 | |||||
| WISE, Richard John | Administrateur | 6 The Leas Longdean Park HP3 8BP Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 59140110002 | |||||
| WOOD, Marlene | Administrateur | 15 Ormidale Terrace EH12 6DY Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 31152030002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CENTROS MILLER 1999 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centros Miller Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 2 Lochside View Edinburgh Park EH12 9DH Edinburgh Miller House United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CENTROS MILLER 1999 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Security document | Créé le 12 mai 2003 Livré le 30 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Land & buildings at wide bargate, threadneedle street, pen street, main ridge west and mitre lane, boston, lincolnshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage of deposited monies | Créé le 04 janv. 2000 Livré le 17 janv. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions A book debt of £88,990 owing by hsbc bank PLC to centro miller limited standing to the credit of an interest earning bank account numbered 9246698 at hsbc bank PLC at its branch at holburn circus or such other account or accounts at any branch of hsbc bank PLC as may from time to time be submitted therefore whether by way of tranfer of monies redesignation or otherwise together with all further sums which may be credited to the account together with all interest accruing thereon and the due benefit and the advantage thereof. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Bond & floating charge | Créé le 18 nov. 1996 Livré le 20 nov. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
CENTROS MILLER 1999 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0