GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED

GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC170383
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    • fabrication de structures métalliques et de parties de structures (25110) / Industries manufacturières

    Où se situe GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Blackwood House
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ROBERTS MACHINING SOLUTIONS LIMITED05 nov. 201405 nov. 2014
    ROBERTS PIPELINE MACHINING LIMITED02 nov. 201102 nov. 2011
    GLACIER ENERGY SERVICES LIMITED11 avr. 201111 avr. 2011
    MBAE OIL & GAS LIMITED28 oct. 201028 oct. 2010
    MBAE SHELF LIMITED28 oct. 201028 oct. 2010
    MB AEROSPACE LIMITED24 juin 199924 juin 1999
    HURSTWELL ROBERTS LIMITED28 nov. 199628 nov. 1996

    Quels sont les derniers comptes de GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au27 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation11 déc. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au27 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Modifications à la charge flottante SC1703830019

    156 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830018

    156 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830024

    156 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830023

    156 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830020

    156 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830021

    156 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1703830024, créée le 06 janv. 2026

    29 pagesMR01

    Modifications à la charge flottante SC1703830022

    157 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830017

    157 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1703830023, créée le 06 janv. 2026

    74 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sandy Smart en tant que directeur le 13 mai 2025

    1 pagesTM01

    Modifications à la charge flottante SC1703830017

    85 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830022

    84 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830018

    83 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830019

    83 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830020

    49 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830021

    83 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1703830022, créée le 26 mars 2025

    21 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 27 nov. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024

    12 pagesAA

    Statuts

    10 pagesMA

    Modifications à la charge flottante SC1703830020

    84 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830021

    84 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1703830018

    84 pages466(Scot)

    Qui sont les dirigeants de GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN, Scott
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    158889440001
    BLACKWOOD PARTNERS LLP
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    Secrétaire
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementSO303063
    168729210001
    MARTIN, Scott
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    ScotlandBritish127620220001
    HAMILTON, Robert Herd
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    Secrétaire
    82 Manse Road
    ML1 2PT Motherwell
    British647140001
    KERR, Gordon William, Finance Director
    PO BOX 4
    Logans Road
    ML1 3NP Motherwell
    Secrétaire
    PO BOX 4
    Logans Road
    ML1 3NP Motherwell
    British120681150001
    MACDONALD, Alexander Alister
    4 Millburn Drive
    PA13 4JF Kilmacolm
    Secrétaire
    4 Millburn Drive
    PA13 4JF Kilmacolm
    British35579400001
    MONTGOMERIE, Ian Morton
    57 Atholl Drive
    Giffnock
    G46 6QW Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    57 Atholl Drive
    Giffnock
    G46 6QW Glasgow
    Lanarkshire
    British69606610001
    POLLAND, Owen
    7 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    Secrétaire
    7 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    British90289570001
    WATSON, Stewart Robert
    Flat 22 Bothwell Grange Main Street
    Uddingston
    G71 7HD Glasgow
    Secrétaire
    Flat 22 Bothwell Grange Main Street
    Uddingston
    G71 7HD Glasgow
    British42504990003
    WHITE, Paul
    58 Dunnock Lane
    Cottam
    PR4 0NK Preston
    Lancs
    Secrétaire
    58 Dunnock Lane
    Cottam
    PR4 0NK Preston
    Lancs
    British66881530002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    BETHEL, Archibald Anderson
    50 Avondale Avenue
    G74 1NS East Kilbride
    Strathclyde
    Administrateur
    50 Avondale Avenue
    G74 1NS East Kilbride
    Strathclyde
    ScotlandBritish47190540003
    DARROCH, Norman
    24 Braemar Grove
    FK15 0DE Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    24 Braemar Grove
    FK15 0DE Dunblane
    Perthshire
    British1093670001
    DERRY, Mark John
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    EnglandBritish178074560001
    GALLAGHER, Craig Richard
    33 Boclair Road
    G61 2AF Bearsden
    Stronvar
    Lanarkshire
    Administrateur
    33 Boclair Road
    G61 2AF Bearsden
    Stronvar
    Lanarkshire
    ScotlandBritish120508900002
    GOUGH, Callum Anthony
    Old Manse Cottage
    Wanlockhead
    ML12 6UR Biggar
    Lanarkshire
    Administrateur
    Old Manse Cottage
    Wanlockhead
    ML12 6UR Biggar
    Lanarkshire
    United KingdomBritish95989750001
    HARRISON, Steven Richard
    54 Uppelby
    Eastingwold
    YO61 3BB York
    Hillside
    Yorkshire
    England
    Administrateur
    54 Uppelby
    Eastingwold
    YO61 3BB York
    Hillside
    Yorkshire
    England
    EnglandBritish135203380001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Administrateur
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritish50729030001
    HUTCHESON, Robert
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    70
    Scotland
    Administrateur
    Queens Road
    AB15 4YE Aberdeen
    70
    Scotland
    United KingdomBritish158889350001
    KERR, Gordon William, Finance Director
    PO BOX 4
    Logans Road
    ML1 3NP Motherwell
    Administrateur
    PO BOX 4
    Logans Road
    ML1 3NP Motherwell
    ScotlandBritish120681150001
    MACDONALD, Alexander Alister
    4 Millburn Drive
    PA13 4JF Kilmacolm
    Administrateur
    4 Millburn Drive
    PA13 4JF Kilmacolm
    ScotlandBritish35579400001
    MCDOUGALL, Duncan Dargie
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    ScotlandBritish161556820001
    MONTGOMERIE, Ian Morton
    57 Atholl Drive
    Giffnock
    G46 6QW Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    57 Atholl Drive
    Giffnock
    G46 6QW Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish69606610001
    PHIMISTER, Bernard George
    9 Brooklime Gardens
    G74 4UB East Kilbride
    South Lanarkshire
    Administrateur
    9 Brooklime Gardens
    G74 4UB East Kilbride
    South Lanarkshire
    United KingdomBritish98998210001
    POLLAND, Owen
    7 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    Administrateur
    7 Carlingnose Point
    KY11 1ER North Queensferry
    British90289570001
    ROBERTS, Gwynne David
    21 Mansewood Drive
    G82 3EU Dumbarton
    Dunbartonshire
    Administrateur
    21 Mansewood Drive
    G82 3EU Dumbarton
    Dunbartonshire
    British390430001
    ROBERTS, Hugh Norman
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    ScotlandBritish390410003
    ROBERTS, Hugh Norman
    Hamarslea Upper Smollett Street
    G83 0LN Alexandria
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Hamarslea Upper Smollett Street
    G83 0LN Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish390410003
    SMART, Sandy
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United KingdomBritish170707260001
    SMART, Sandy
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United KingdomBritish170707260001
    STURROCK, David
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    Administrateur
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    United Kingdom
    ScotlandBritish149461550001
    WATSON, Stewart Robert
    Flat 22 Bothwell Grange Main Street
    Uddingston
    G71 7HD Glasgow
    Administrateur
    Flat 22 Bothwell Grange Main Street
    Uddingston
    G71 7HD Glasgow
    British42504990003
    WHITE, Paul
    58 Dunnock Lane
    Cottam
    PR4 0NK Preston
    Lancs
    Administrateur
    58 Dunnock Lane
    Cottam
    PR4 0NK Preston
    Lancs
    British66881530002
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GLACIER MACHINING SOLUTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Glacier Energy Services Holdings Limited
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    06 avr. 2016
    Union Grove Lane
    AB10 6XU Aberdeen
    Blackwood House
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Scotland
    Numéro d'enregistrementSc393101
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0