SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED

SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC172022
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    • Octroi de crédit par les établissements financiers non-dépositaires et autres octroyeurs spécialisés de crédit à la consommation (64921) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    G1, 5 George Square
    G2 1DY Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOUTHGATE RETAIL PARK LIMITED26 mars 199726 mars 1997
    PACIFIC SHELF 711 LIMITED04 févr. 199704 févr. 1997

    Quels sont les derniers comptes de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 301 st Vincent Street Glasgow G2 5AB le 16 oct. 2012

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 oct. 2012

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 févr. 2012

    État du capital au 14 févr. 2012

    • Capital: GBP 1,100,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Sandra Huckle en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sandra Dawn Huckle le 05 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Moss le 15 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael John Merrick le 05 mars 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 févr. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Andrew Moss en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kerr Luscombe en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael John Merrick en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    13 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    13 pagesAA

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PEARL GROUP SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    Secrétaire
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    115204320002
    MERRICK, Michael John
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish74114060001
    MOSS, Andrew
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    United KingdomBritish151524430001
    COUPE, Ernest Peter
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    Secrétaire
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    British38314970001
    HENDERSON, Gordon
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    British344750001
    MCEWAN, Allan David
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    British51216260001
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    British39851670003
    ABBEY NATIONAL SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    Secrétaire
    Abbey National House
    2 Triton Square Regent's Place
    NW1 3AN London
    61749570003
    MD SECRETARIES (EDINBURGH) LIMITED
    Pacific House
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Secrétaire
    Pacific House
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    43825370001
    ALI, Yacub
    Telfer House
    Garrion Bridge
    ML9 2UB Larkhall
    Administrateur
    Telfer House
    Garrion Bridge
    ML9 2UB Larkhall
    British2450001
    COLES, Shaun Patrick
    Chaplin Walk
    Great Cornard
    CO10 0YT Sudbury
    4
    Suffolk
    Administrateur
    Chaplin Walk
    Great Cornard
    CO10 0YT Sudbury
    4
    Suffolk
    United KingdomBritish95706540001
    COUPE, Ernest Peter
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    Administrateur
    8 Blackbarony Road
    EH16 5QP Edinburgh
    Scotland
    British38314970001
    HENDERSON, Gordon
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    Surrenden Lodge 23 Cammo Crescent
    EH4 8DZ Edinburgh
    Midlothian
    British344750001
    HUCKLE, Sandra Dawn
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    Administrateur
    Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6WG Birmingham
    1
    England
    EnglandBritish133348730001
    LINDSAY, Kenneth Fraser
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    61 Muir Wood Crescent
    Currie
    EH14 5HB Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish121520410001
    LUSCOMBE, Kerr
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    Administrateur
    3e Melbourne Court
    Braidpark Drive, Giffnock
    G46 6LA Glasgow
    ScotlandBritish83541890001
    MACGARVIE, James Stuart
    22 Garden Street
    KA4 8HX Galston
    Ayrshire
    Administrateur
    22 Garden Street
    KA4 8HX Galston
    Ayrshire
    British74305300001
    MACKIE, Colin Mathison
    5 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    Administrateur
    5 Wellington Terrace
    ML11 7QQ Lanark
    ScotlandBritish36377590001
    MCEWAN, Allan David
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    8 Glen Farrar Way
    KA2 0LP Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish51216260001
    MCLELLAN, William Lawrence
    56 Glenalla Crescent
    Alloway
    KA7 4DA Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    56 Glenalla Crescent
    Alloway
    KA7 4DA Ayr
    Ayrshire
    British4618630001
    PATERSON, John Edward
    23 Braeburn Drive
    EH14 6AQ Currie
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    23 Braeburn Drive
    EH14 6AQ Currie
    Midlothian
    Scotland
    British59174260002
    POTTINGER, Graham Robert
    1 Gotter Bank
    Quarriers Village
    PA11 3NX Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    1 Gotter Bank
    Quarriers Village
    PA11 3NX Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British33361050003
    RAMSAY, Caroline
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Maclean Place
    Bishopbriggs
    G64 3BJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish39851670003
    SINGLETON, Graham Lloyd
    High Meadow
    Alderminster
    CV37 8NX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    High Meadow
    Alderminster
    CV37 8NX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British63550740005
    WATT, Charles
    Roseholm 7 Orchard Leigh
    St Nicholas Hill
    KT22 8NE Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Roseholm 7 Orchard Leigh
    St Nicholas Hill
    KT22 8NE Leatherhead
    Surrey
    British55295300001
    WOODS, David Ernest
    20 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    20 Midmar Drive
    EH10 6BU Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish344760001
    WRIGHT, Jason Leslie
    Sandford Lodge
    21 Reading Road
    OX10 9DS Wallingford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Sandford Lodge
    21 Reading Road
    OX10 9DS Wallingford
    Oxfordshire
    British72145280003
    MD DIRECTORS LIMITED
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    Administrateur désigné
    70 Wellington Street
    G2 6SB Glasgow
    Pacific House
    900005100001

    SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 07 juil. 1997
    Livré le 10 juil. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots and areas of ground at cathcart road and crown street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 10 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 07 juil. 1997
    Livré le 10 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots and or areas of ground at cathcart road and crown street glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 10 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 02 juil. 1997
    Livré le 04 juil. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Charterhouse Bank Limited
    Transactions
    • 04 juil. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 juil. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 29 juil. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 02 juin 1997
    Livré le 11 juin 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground to the northwest of crown street,glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Provident Institution
    Transactions
    • 11 juin 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 23 avr. 1997
    Livré le 24 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Provident Institution
    Transactions
    • 24 avr. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 juil. 1997Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    SOUTH GLASGOW RETAIL PARK LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 mars 2014Dissolved on
    09 oct. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0