TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED

TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC175671
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7-11 Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TULLOCH HOMES GROUP LIMITED03 déc. 199703 déc. 1997
    TULLOCH HOMES (GROUP) LIMITED28 oct. 199728 oct. 1997
    TULLOCH HOMES (HOLDINGS) LIMITED23 sept. 199723 sept. 1997
    PACIFIC SHELF 732 LIMITED21 mai 199721 mai 1997

    Quels sont les derniers comptes de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    12 pagesLIQ13(Scot)

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC08

    Cessation de Tulloch Homes (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 mars 2019

    1 pagesPSC07

    Changement d'adresse du siège social de Stoneyfield House Stoneyfield Business Park Inverness IV2 7PA à 7-11 Melville Street Edinburgh EH3 7PE le 05 juil. 2018

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 juin 2018

    LRESSP

    Satisfaction de la charge SC1756710006 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Macdonald le 27 juin 2018

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2017

    13 pagesAA

    legacy

    34 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 23 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2016

    13 pagesAA

    legacy

    35 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 avr. 2016

    État du capital au 25 avr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA

    legacy

    35 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alexander James Grant le 07 janv. 2016

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FRASER, George Gabriel
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    ScotlandBritish50219540001
    GRANT, Alexander James
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    United KingdomBritish113195780003
    MACDONALD, Ian
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    Administrateur
    Melville Street
    EH3 7PE Edinburgh
    7-11
    ScotlandBritish81926330001
    CAMERON, James
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Secrétaire
    Stoneyfield House
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    British166632500001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Secrétaire
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    British145418810001
    SUTHERLAND, Caroline Anne
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    Secrétaire
    Slackbuie Way
    Fairways
    IV2 6AT Inverness
    29
    United Kingdom
    British87534020003
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Secrétaire
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BALLINGALL, Stuart James
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    Administrateur
    78/10 Orchard Brae Avenue
    EH4 2GA Edinburgh
    Midlothian
    Scotland
    British57693580001
    BARKLEY, John
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    Administrateur
    10 Willow Tree Place
    The Beeches
    EH14 5AZ Balerno
    Edinburgh, Midlothian
    British18955940002
    BRAZIER, Stephen Harvey
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Russett House, 8 Main Drive
    SL9 7PS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100183520001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Administrateur
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    CAMERON, Neil Stuart
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    Administrateur
    30 Overton Avenue
    IV3 6RR Inverness
    ScotlandBritish34848670001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    MACDONALD, Ronald Sutherland
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    Administrateur
    135 Stewarton Drive
    G72 8DH Cambuslang
    United KingdomBritish145418810001
    MACDOUGALL, Alasdair
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    Administrateur
    104 Culduthel Park
    IV2 4RZ Inverness
    Highland
    ScotlandBritish91007550001
    MACKENZIE, Donald Henry
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    Taighe-Na-Coille Dalgrambich
    Croy
    IV2 5PR Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish66483050001
    MACLENNAN, Fiona
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    Administrateur
    Steinnola
    7 Macleod Place
    IV15 9TZ Dingwall
    Ross Shire
    British45638410001
    MACRAE, Gordon Major Robson
    8 Drummond Crescent
    IV2 4QW Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    8 Drummond Crescent
    IV2 4QW Inverness
    Inverness Shire
    InvernessBritish19800001
    MARSHALL, Alyson
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    Administrateur
    8 Blackthorn Avenue
    G66 4BZ Kirkintilloch
    Lanarkshire
    ScotlandBritish116919700001
    MCARTHUR, Robert Johnstone
    Almond House, 8 Burrell Street
    PH7 4DR Crieff
    Perthshire
    Administrateur
    Almond House, 8 Burrell Street
    PH7 4DR Crieff
    Perthshire
    British81926300001
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    MELVILLE, Gordon
    19 Fishers Green
    FK9 4PU Bridge Of Allan
    Administrateur
    19 Fishers Green
    FK9 4PU Bridge Of Allan
    British91539740001
    MONKS, Charles
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    Administrateur
    116 Vere Road
    Blackwood
    ML11 9QF Lanark
    Midlothian
    ScotlandBritish62550910001
    PETERS, Douglas
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    8 Margaret Rose Loan
    EH10 7EQ Edinburgh
    Midlothian
    British108781900001
    SUTHERLAND, David Fraser
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    Administrateur
    Oldtown Of Leys Farm
    Culduthel
    IV2 6AE Inverness
    ScotlandBritish1321720003
    TORRANCE, Susan Margaret
    Caberfeidh
    Upper Rosemount
    IV19 1ND Tain
    Highland
    Administrateur
    Caberfeidh
    Upper Rosemount
    IV19 1ND Tain
    Highland
    United KingdomBritish91050230001
    TRACE, Marjory Bremner
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    Administrateur
    1 Wellside Road
    Balloch
    IV2 7GS Inverness
    British43522850004
    WRIGHT, Donald James
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    Administrateur
    Griannan
    St Leonards Road
    IV36 2RE Forres
    Moray
    ScotlandBritish75244500002
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    06 avr. 2016
    Stoneyfield Business Park
    IV2 7PA Inverness
    Stoneyfield House
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc277497
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    12 mars 2019La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2015
    Livré le 06 mars 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 29 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 16 déc. 2009
    Livré le 22 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Playing field to south of bent road, hamilton LAN197626 under exception- see form for further details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 29 avr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 02 nov. 2006
    Livré le 16 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    That plot or area of ground extending to 0.164 hectares or thereby lying to the north west side of grampian road/main road aviemore being the B9152.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 10 févr. 2003
    Livré le 19 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    92 raeberry street, glasgow--title number GLA50417.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 nov. 1997
    Livré le 19 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 19 nov. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    TULLOCH HOMES GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juin 2018Commencement of winding up
    05 août 2022Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0