MACFARLANE HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMACFARLANE HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC177670
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o FRP ADVISORY LLP
    Apex 3 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MACFARLANE CONSTRUCTION LIMITED 04 août 199704 août 1997

    Quels sont les derniers comptes de MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    4 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    13 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 160 Dundee Street Edinburgh EH11 1DQ le 12 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    12 pages2.20B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    13 pages2.16B(Scot)

    État des affaires avec formulaire 2.14B(SCOT)/2.13B(SCOT)

    47 pages2.15B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh Midlothian EH3 8HE le 11 août 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    21 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    20 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MACFARLANE HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LINDSAYS WS
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Lothian
    Secrétaire
    19a Canning Street
    EH3 8HE Edinburgh
    Caledonian Exchange
    Lothian
    110222460001
    CORDINER, William Neil
    Beanshill Cottage
    Contlaw Road Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    Administrateur
    Beanshill Cottage
    Contlaw Road Milltimber
    AB13 0EJ Aberdeen
    United KingdomBritish572260002
    MACCUISH, Duncan Malcolm
    16 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    16 Braid Avenue
    EH10 6EE Edinburgh
    Midlothian
    British876490001
    MACFARLANE, Angus William
    Rutherford Gardens
    EH46 7AP West Linton
    1
    Peeblesshire
    Administrateur
    Rutherford Gardens
    EH46 7AP West Linton
    1
    Peeblesshire
    United KingdomBritish54043360003
    ORR MACQUEEN WS
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Secrétaire désigné
    36 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    900000160001
    SKENE EDWARDS WS
    5 Albyn Place
    EH2 4NJ Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire désigné
    5 Albyn Place
    EH2 4NJ Edinburgh
    Midlothian
    900028880001
    BARCLAY, Nicola
    36 Liberton Gardens
    EH16 6JS Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    36 Liberton Gardens
    EH16 6JS Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish117506110001
    CUNNINGHAM, Malcolm Hannay
    Mavisbank
    EH18 1HY Lasswade
    The Barn
    Midlothian
    Administrateur
    Mavisbank
    EH18 1HY Lasswade
    The Barn
    Midlothian
    United KingdomBritish108581290002
    HUTTON, Elizabeth Jean
    16 Rose Avenue
    EH19 3RD Bonnyrigg
    Midlothian
    Administrateur
    16 Rose Avenue
    EH19 3RD Bonnyrigg
    Midlothian
    British112942080001
    LAW, Robert
    5/6 Joppa Station Place
    Joppa
    EH15 2QU Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    5/6 Joppa Station Place
    Joppa
    EH15 2QU Edinburgh
    Midlothian
    British109922260001
    MACFARLANE, John Caldwell
    Willowfield Darlington Road
    DL12 8HN Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    Willowfield Darlington Road
    DL12 8HN Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish2306120001
    MACFARLANE, Judith Helen
    Rutherford House
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    Administrateur
    Rutherford House
    EH46 7AS West Linton
    Peeblesshire
    British54043350002
    SMITH, William Martin
    4 Suffolk Road
    EH16 5NR Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    4 Suffolk Road
    EH16 5NR Edinburgh
    Midlothian
    British113078240001

    MACFARLANE HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 12 déc. 2007
    Livré le 27 déc. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The steading, rochsoles farm, raebog road, glenmavis, airdrie.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 27 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 oct. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    4 powdermill brae, gorebride.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 12 avr. 2007
    Livré le 14 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area or piece of ground extending to 2.1183 hectares or thereby part and portion of holmes smallholding number six, broxburn and area of ground at holmes west, broxburn.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 avr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 26 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • William Neil Cordiner
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 05 oct. 2005
    Livré le 21 oct. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    2.71 hectares of ground part of the lands and estates of rutherford, parish of linton, county of peebles PBL3150.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 oct. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 08 sept. 2005
    Livré le 28 sept. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Rutherford house west linton peebles.
    Personnes ayant droit
    • Mr William Neil Cordiner
    Transactions
    • 28 sept. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 06 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of a loan agreement dated 7 september and 28 october 2004
    Brèves mentions
    Subjects at glenyards road, bonnybridge (title number STG35614); an area of ground at glenyards road, bonnybridge (title number STG47153) and an area of ground at glenyards road, bonnybridge.
    Personnes ayant droit
    • William Neil Cordiner
    Transactions
    • 06 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 02 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property known as and forming the subjects at glenyards, bonnybridge in the county of stirling (title number stg 35614).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 nov. 2004
    Livré le 23 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Caskieberran road, glenrothes FFE71359.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 nov. 2004
    Livré le 17 nov. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    (One) two areas of ground extending to 0.894 hectares and 0.1065 hectares at caskieberran road, glenrothes and (second) area of ground containing 4.699 acres at caskieberran road, glenrothes.
    Personnes ayant droit
    • William Neil Cordiner
    Transactions
    • 17 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 sept. 2004
    Livré le 17 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Former site of 538,540 & 542 main street & subjects to north east of main street, wishaw.
    Personnes ayant droit
    • William Neil Cordiner
    Transactions
    • 17 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 sept. 2004
    Livré le 10 sept. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The property known as the subjects at main street, wishaw being the former site of 538, 540 and 540 main street, wishaw and ground lying to the north east of main street, wishaw (title numbers LAN154027 and LAN133969).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 sept. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 août 1997
    Livré le 08 sept. 1997
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 sept. 1997Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 sept. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 02 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 oct. 2005Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 avr. 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    MACFARLANE HOMES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 août 2010Administration started
    04 août 2011Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kenneth Robert Craig
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    practitioner
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    Thomas Campbell Maclennan
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    practitioner
    160 Dundee Street
    Edinburgh
    EH11 1DQ
    2
    DateType
    04 août 2011Commencement of winding up
    09 avr. 2015Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kenneth Robert Craig
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    practitioner
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Thomas Campbell Maclennan
    Tenon Recovery
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    practitioner
    Tenon Recovery
    160 Dundee Street
    EH11 1DQ Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0