GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC178615 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit C, Ground Floor, Cirrus Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Paisley |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 22 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 08 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant qu'administrateur le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Canty en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Sara Hollowell en tant que secrétaire le 01 oct. 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2024 | 5 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Andrew Lonnon en tant que directeur le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que directeur le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 24 avr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Jennifer Canty en tant qu'administrateur le 24 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2023 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant qu'administrateur le 21 sept. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que directeur le 21 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2022 | 5 pages | AA | ||
Nomination de Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin en tant que secrétaire le 07 juil. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Katherine Elizabeth Hindmarsh en tant que secrétaire le 07 juil. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2021 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2020 | 5 pages | AA | ||
Inscription de la charge SC1786150024, créée le 22 mars 2021 | 5 pages | MR01 | ||
Qui sont les dirigeants de GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLOWELL, Sara | Secrétaire | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | 340891250001 | |||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 330353690001 | |||||
| HOLLOWELL, Sara | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 200486170001 | |||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | 311035480001 | |||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147317680001 | |||||||
| BORT, Stefan Edward | Secrétaire | 126 Grove Park SE5 8LD London | British | 32824200005 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Secrétaire | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | 322297040001 | |||||||
| CARR, Peter Anthony | Secrétaire | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | 130306120001 | ||||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Secrétaire | Scotland Street Stoke By Nayland CO6 4QF Colchester Homestead Essex | Other | 135438270002 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Secrétaire | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219912930001 | |||||||
| JORDAN, James John | Secrétaire | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Secrétaire | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 166109560001 | |||||||
| PHILLIPS, James | Secrétaire | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | 8364990001 | ||||||
| ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo | Administrateur | Turnpike Road HP12 3 NR High Wycombe Gate House Bucks United Kingdom | United Kingdom | British | 193735640001 | |||||
| ANDREW, Peter Robert | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 113503830003 | |||||
| ARMSTRONG, Karen Jean | Administrateur | Beechmount Park EH12 5YT Edinburgh 9 | United Kingdom | British | 137938400001 | |||||
| BRADY, Tracey Jaynne | Administrateur | 14 King Malcolm Close Kings Manor EH10 7JB Edinburgh Midlothian | British | 75721390004 | ||||||
| BROWN, Simon Christopher | Administrateur | 105 Woodfield Avenue EH13 0QR Edinburgh Mid-Lothian | United Kingdom | British | 113724050001 | |||||
| BURNS, William Rae | Administrateur | 8 Redhill Road Balloch G68 9AS Cumbernauld Glasgow | British | 75721190001 | ||||||
| CANTY, Jennifer | Administrateur | Glasgow Airport Business Park Marchburn Drive PA3 2SJ Abbotsinch Unit C, Ground Floor, Cirrus Paisley | United Kingdom | British | 322288120001 | |||||
| CARNEY, Christopher | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 125216670001 | |||||
| CARR, Peter Anthony | Administrateur | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | 130306120001 | |||||
| CLAPHAM, Colin Richard | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 9684390001 | |||||
| CUSHEN, Keith Morgan | Administrateur | Buddleia Cottage High Street TW12 2SX Hampton Middlesex | British | 37763770002 | ||||||
| FRAME, Martin Mcfarlane | Administrateur | 47 Victoria Street AB39 2LH Stonehaven Aberdeenshire | British | 105621870001 | ||||||
| HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Administrateur | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | 76844970003 | ||||||
| HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 257671040002 | |||||
| JENKINS, Stephen Adrian | Administrateur | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | 49738660003 | |||||
| LONNON, Michael Andrew, Mr. | Administrateur | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 34521340004 | |||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Administrateur | 6 Cupar Road KY8 6DQ Lundin Links The Stables Fife United Kingdom | Scotland | British | 147233120001 | |||||
| MILLER, Allan | Administrateur | 18 Ashburnham Gardens South Queensferry EH30 9LB Edinburgh | Scotland | British | 156679100001 | |||||
| MURRIN, Jonathan Charles | Administrateur | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | 115863170001 | ||||||
| NAYSMITH, Michael Grieve | Administrateur | Stonefield Cottage Durno, Pitcaple AB51 5EP Inverurie Aberdeenshire | United Kingdom | British | 103528680001 | |||||
| PALMER, David William | Administrateur | 23 Masonfield Avenue Balloch G68 9DW Cumbernauld Lanarkshire | British | 107741940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GEORGE WIMPEY EAST SCOTLAND LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Wimpey Uk Limited | 06 avr. 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0