COVESEA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOVESEA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC178693
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COVESEA LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe COVESEA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    2nd Floor 11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COVESEA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PACIFIC SHELF 748 LIMITED10 sept. 199710 sept. 1997

    Quels sont les derniers comptes de COVESEA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour COVESEA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    4 pagesDS01

    Nomination de Mr Peter John Sheldrake en tant qu'administrateur le 02 déc. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Fulton Gilmour en tant que directeur le 02 déc. 2021

    1 pagesTM01

    État du capital au 02 déc. 2021

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    Subdivision des actions au 18 nov. 2021

    6 pagesSH02

    legacy

    2 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sub-division approved 18/11/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 10 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 août 2020

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 sept. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2019

    24 pagesAA

    Cessation de la nomination de Ian Clark en tant que directeur le 20 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 20 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 19 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de COVESEA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement05372427
    128530180002
    CAVILL, John Ivor
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    Administrateur
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United KingdomBritish152521640006
    ROBERTSON, Hilda Mary
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    Administrateur
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish141781310001
    ROBERTSON, William George
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    Administrateur
    Dun Donnachaidh
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Morayshire
    ScotlandBritish88810130001
    SHELDRAKE, Peter John
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    Administrateur
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    EnglandBritish164986530026
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Secrétaire
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Secrétaire
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Secrétaire
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Secrétaire
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    BUXTON, Peter Nigel John
    15 Biggin Lane
    PE26 1NB Ramsey
    Cambs
    Administrateur
    15 Biggin Lane
    PE26 1NB Ramsey
    Cambs
    United KingdomBritish113651410001
    CLARK, Ian
    1 St Peter's Lane
    IV30 5WA Duffus
    Jasmine Cottage
    Morayshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1 St Peter's Lane
    IV30 5WA Duffus
    Jasmine Cottage
    Morayshire
    United Kingdom
    ScotlandBritish168569590001
    CLARKE, Laurence Seymour
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    Administrateur
    Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc, 1
    EnglandBritish138241960001
    FULLERTON, Robert Souter
    26 Quarry Avenue
    Cambuslang
    G72 8UF Glasgow
    Administrateur
    26 Quarry Avenue
    Cambuslang
    G72 8UF Glasgow
    ScotlandBritish14305850002
    FULLERTON, Robert Souter
    26 Quarry Avenue
    Cambuslang
    G72 8UF Glasgow
    Administrateur
    26 Quarry Avenue
    Cambuslang
    G72 8UF Glasgow
    ScotlandBritish14305850002
    GILMOUR, David Fulton
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    Administrateur
    c/o Infrastructure Managers Limited
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd Floor
    United KingdomBritish158508150001
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    HOPE, John Alexander
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    Administrateur
    Eildon, 17 Craigielaw Park
    Aberlady
    EH32 0PR Longniddry
    East Lothian
    United KingdomBritish71318590003
    MACKINTOSH, William James
    1 Toward Court
    Craigievar Wynd
    EH12 8GR Edinburgh
    Administrateur
    1 Toward Court
    Craigievar Wynd
    EH12 8GR Edinburgh
    British76530400001
    MARTIN, Joseph Michael
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    Administrateur
    8 Mill View School Lane
    Eaton Socon
    PE19 3HJ St Neots
    Cambridgeshire
    British1092550002
    POPE, Anthony
    14 Merlin Park
    FK14 7BZ Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    14 Merlin Park
    FK14 7BZ Dollar
    Clackmannanshire
    British50323440001
    RICHARDS, Andrew Scott
    2 Park Road
    Eskbank
    EH22 3DF Dalkeith
    Midlothian
    Administrateur
    2 Park Road
    Eskbank
    EH22 3DF Dalkeith
    Midlothian
    ScotlandBritish99426610001
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Administrateur
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    THORNTON, Jeffrey Michael
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    Administrateur
    108 March Road
    EH4 3SX Edinburgh
    United KingdomBritish19241770002
    WARBURTON, Lesley Anne
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    8 Cranberry Drive
    BL3 4TB Bolton
    Lancashire
    British64383520002
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Administrateur
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06793845
    138240210001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COVESEA LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    25 Ropemaker Street
    EC2Y 9AN London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    25 Ropemaker Street
    EC2Y 9AN London
    Ropemaker Place
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement00924205
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mrs Hilda Mary Robertson
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr William George Robertson
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    44 Hamilton Drive
    IV30 4NL Elgin
    Dun Donnachaidh
    Morayshire
    United Kingdom
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    2nd Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    C/O Infrastructure Managers Limited
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    2nd Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    C/O Infrastructure Managers Limited
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc178695
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 50 % mais pas plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    COVESEA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 07 févr. 2017
    Livré le 08 févr. 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Btmu (Europe) Limited
    Transactions
    • 08 févr. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 02 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 févr. 2012
    Livré le 17 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plot or piece of ground at coulardbank lossiemouth see form for details.
    Personnes ayant droit
    • Btmu (Europe) Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 févr. 2012
    Livré le 17 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground lying in the burgh of lossiemouth and branderburgh see form for details.
    Personnes ayant droit
    • Btmu (Europe) Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 févr. 2012
    Livré le 17 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground extending to 3.646 hectares lying in the parish of drainie please see form for details.
    Personnes ayant droit
    • Btmu (Europe) Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 06 févr. 2012
    Livré le 17 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two areas of ground at covesea road elgin please see form for details.
    Personnes ayant droit
    • Btmu (Europe) Limited
    Transactions
    • 17 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 16 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at covesea road,elgin.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 16 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 16 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.512 ha of ground in the burgh of lossiemouth and branderburgh,county of moray.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 16 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 16 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.638 ha at coulardbank,lossiemouth,moray.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 16 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 03 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 16 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.646 ha at drainie,moray.
    Personnes ayant droit
    • The Secretary of State for Defence
    Transactions
    • 16 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.646 hectares at drainie,moray.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Two areas of ground at covesea road,elgin.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.638 ha of ground at coulardbank,lossiemouth.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 03 juil. 1998
    Livré le 15 juil. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    0.512 ha in the burgh of lossiemouth.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 nov. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignation of contracts
    Créé le 12 juin 1998
    Livré le 26 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole right,title and interest under the contracts.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 26 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 12 juin 1998
    Livré le 26 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 26 juin 1998Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 26 juin 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 févr. 2012Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 29 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0