ANDSTRAT (NO.422) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéANDSTRAT (NO.422) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC180437
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mlm Solutions
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARNEGIE ENTERPRISE LIMITED30 nov. 200730 nov. 2007
    ENTERPRISE LAUDER LIMITED15 janv. 199815 janv. 1998
    CHEVIOTROM LIMITED10 nov. 199710 nov. 1997

    Quels sont les derniers comptes de ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte final avant dissolution dans MVL (compte final attaché)

    19 pagesLIQ13(Scot)

    Cessation de la nomination de David Peter Colman en tant que directeur le 17 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Mlm Solutions 7th Floor 90 st. Vincent Street Glasgow G2 5UB à C/O Mlm Solutions 4/2 100 West Regent Street Glasgow Scotland G2 2QD le 11 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed carnegie enterprise LIMITED\certificate issued on 22/01/19
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name22 janv. 2019

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Changement d'adresse du siège social de Fife College Pittsburgh Road Halbeath Dunfermline Fife KY11 8DY à C/O Mlm Solutions 7th Floor 90 st. Vincent Street Glasgow G2 5UB le 07 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2018

    LRESSP

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2018

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 juil. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr James Trail en tant qu'administrateur le 28 juin 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Derek William Birkenfield en tant que directeur le 05 avr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Hugh Hall en tant qu'administrateur le 01 mars 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alastair David Neilson en tant que directeur le 28 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2016

    16 pagesAA

    Nomination de Mrs Jennifer Dawn Walls en tant qu'administrateur le 01 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alastair David Neilson en tant qu'administrateur le 01 nov. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hugh Logan en tant que directeur le 31 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr David Peter Colman en tant qu'administrateur le 06 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jan Thomson en tant qu'administrateur le 29 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Deborah Miller en tant que directeur le 31 août 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven John Harrison en tant que directeur le 03 mai 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PHILP, Marianne Dawn
    Garvock Terrace
    KY12 7UA Dunfermline
    50
    Fife
    Scotland
    Secrétaire
    Garvock Terrace
    KY12 7UA Dunfermline
    50
    Fife
    Scotland
    British86534740003
    COCHRANE, Shona Bowman
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    ScotlandBritish181842660001
    HALL, Hugh
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    United KingdomBritish133608600002
    THOMSON, Jan
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    ScotlandBritish215250840001
    TRAIL, James
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    ScotlandBritish235229570001
    WALLS, Jennifer Dawn
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    ScotlandBritish218652960001
    SCOTT, Russell James Walker
    5 Howdenhall Drive
    EH16 6UL Edinburgh
    Lothian
    Secrétaire
    5 Howdenhall Drive
    EH16 6UL Edinburgh
    Lothian
    British56476020001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    AINSLIE, Stuart
    76 Perth Road
    KY4 9BG Cowdenbeath
    Fife
    Administrateur
    76 Perth Road
    KY4 9BG Cowdenbeath
    Fife
    British105389550001
    BELL, Susan Margaret
    29/6 Fettes Row
    EH3 6RL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    29/6 Fettes Row
    EH3 6RL Edinburgh
    Midlothian
    British66597320001
    BIRKENFIELD, Derek William
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    ScotlandBritish191536760001
    BOWSTEAD, Graham John
    14 Mavisbank
    KY13 8QR Kinross
    Kinross-Shire
    Administrateur
    14 Mavisbank
    KY13 8QR Kinross
    Kinross-Shire
    British1175630002
    BULLOCH, Janet
    Dachaidh
    Abercrombie
    KY10 2DE Anstruther
    Fife
    Administrateur
    Dachaidh
    Abercrombie
    KY10 2DE Anstruther
    Fife
    ScotlandBritish114300170001
    CARNEGIE, Jacqueline
    19 Bowhouse Drive
    KY1 1SB Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    19 Bowhouse Drive
    KY1 1SB Kirkcaldy
    Fife
    British86534710001
    CARNEGIE, Jaki
    18 Bowhouse Drive
    KY1 1SB Kirkcaldy
    Fife
    Administrateur
    18 Bowhouse Drive
    KY1 1SB Kirkcaldy
    Fife
    British56476130002
    CLYNE, Alexander Thomas
    8 Glen View
    EH51 0PQ Boness
    West Lothian
    Uk
    Administrateur
    8 Glen View
    EH51 0PQ Boness
    West Lothian
    Uk
    ScotlandBritish52096290002
    COLMAN, David Peter
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    Administrateur
    4/2 100 West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    C/O Mlm Solutions
    Scotland
    ScotlandBritish86431130001
    COMRIE, Andrew Kennedy
    43 King Street
    PH2 8JB Perth
    Perth And Kinross
    Administrateur
    43 King Street
    PH2 8JB Perth
    Perth And Kinross
    GbrBritish111229740001
    CONDIE, Alan David
    19 Alderston Drive
    KY12 0XU Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    19 Alderston Drive
    KY12 0XU Dunfermline
    Fife
    British44303180001
    COX, Janet Ann
    15 Burleigh Crescent
    KY11 1DQ Inverkeithing
    Fife
    Administrateur
    15 Burleigh Crescent
    KY11 1DQ Inverkeithing
    Fife
    British74629100001
    CURRIE, David John Raphael
    24 Lumsden Crescent
    KY16 9NQ St Andrews
    Fife
    Administrateur
    24 Lumsden Crescent
    KY16 9NQ St Andrews
    Fife
    British111462460001
    DALZIEL, Graeme Davies
    1 Johnsburn Park
    Balerno
    EH14 7NA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    1 Johnsburn Park
    Balerno
    EH14 7NA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish178428020001
    DARGAN, John
    50 Charles Way
    Limekilns
    KY11 3LH Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    50 Charles Way
    Limekilns
    KY11 3LH Dunfermline
    Fife
    United KingdomBritish47480350004
    EDIE, Wendy
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    ScotlandBritish108100120002
    FENLON, Geoffrey Thomas
    Pittsburgh Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Carnegie College
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Carnegie College
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish73661530001
    FINDLAY, Ruth
    25 Venturefair Avenue
    KY12 0PF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    25 Venturefair Avenue
    KY12 0PF Dunfermline
    Fife
    British107091650001
    GARDNER, Anne Agnes
    17 Curlew Gardens
    KY11 8GF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    17 Curlew Gardens
    KY11 8GF Dunfermline
    Fife
    ScotlandBritish59611650002
    GARMORY, Bob
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritish180444030001
    GREIG, Linda
    2 Ashley Avenue
    FK14 7EG Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    2 Ashley Avenue
    FK14 7EG Dollar
    Clackmannanshire
    UkBritish115249850001
    HARRISON, Steven John
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritish154825140001
    LAIRD, Campbell Doull
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    Administrateur
    6 Havens Edge
    KY11 3LJ Limekilns
    Fife
    ScotlandBritish46830610001
    LISTER, Brian George Hamilton
    49 Upper Kinneddar
    KY12 9TR Saline
    Fife
    Administrateur
    49 Upper Kinneddar
    KY12 9TR Saline
    Fife
    United KingdomBritish79150800001
    LOGAN, Hugh
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    Pittsburgh Road
    Halbeath
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    Scotland
    ScotlandBritish101209700001
    LOWE, Janet, Dr
    42 Gamekeepers Road
    Kinnesswood
    KY13 9JR Kinross
    Perth & Kinross
    Administrateur
    42 Gamekeepers Road
    Kinnesswood
    KY13 9JR Kinross
    Perth & Kinross
    United KingdomBritish127861300001
    MCGANN, Stuart Charles
    c/o C/O Carnegie College
    Halbeath Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Carnegie Conference Centre
    Fife
    Scotland
    Administrateur
    c/o C/O Carnegie College
    Halbeath Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Carnegie Conference Centre
    Fife
    Scotland
    United KingdomBritish158961840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ANDSTRAT (NO.422) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Board Of Governors Of Fife College
    Pittsburgh Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    United Kingdom
    28 avr. 2016
    Pittsburgh Road
    KY11 8DY Dunfermline
    Fife College
    Fife
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueIncorporated College
    Autorité légaleFurther And Higher Education (Scotland) Act 1992
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    ANDSTRAT (NO.422) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juil. 2022Dissolved on
    19 déc. 2018Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0