SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED

SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC181237
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Erskine House 68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    O.I.L. CORPORATE LIMITED13 mai 199813 mai 1998
    BAPTISTA LIMITED03 déc. 199703 déc. 1997

    Quels sont les derniers comptes de SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    11 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    7 pages2.20B(Scot)

    Avis de prolongation de la période d'administration

    1 pages2.22B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    28 pages2.16B(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 12-16 Albyn Place Aberdeen AB10 1PS le 15 mars 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2010

    État du capital au 07 janv. 2010

    • Capital: GBP 124,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Terence David Willox le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Masson le 03 déc. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Raeburn Christie Clark & Wallace le 03 déc. 2009

    2 pagesCH04

    Cessation de la nomination de John Burgess en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Julie Cowie en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bruce Gill en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    20 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    5 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    5 pages410(Scot)

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Statuts

    16 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAEBURN CHRISTIE CLARK & WALLACE
    Albyn Place
    AB10 1PS Aberdeen
    12-16
    United Kingdom
    Secrétaire
    Albyn Place
    AB10 1PS Aberdeen
    12-16
    United Kingdom
    Forme juridiqueSCOTTISH PARTNERSHIP (UNLIMITED)
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleSCOTS LAW
    35622500003
    MASSON, David
    18 Charleston Circle
    AB12 3EY Aberdeen
    Administrateur
    18 Charleston Circle
    AB12 3EY Aberdeen
    United KingdomBritish58565940001
    MCGEEHAN, Christopher
    131 Grandholm Drive
    Bridge Of Don
    AB22 8AE Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    131 Grandholm Drive
    Bridge Of Don
    AB22 8AE Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish118503110001
    WILLOX, Terence David
    56 Dawson Drive
    Skene
    AB32 6NS Westhill
    Aberdeenshire
    Administrateur
    56 Dawson Drive
    Skene
    AB32 6NS Westhill
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish123197880001
    MIDDLETON, Sandra Elizabeth
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000270001
    WILLOX, Terence David
    56 Dawson Drive
    Skene
    AB32 6NS Westhill
    Aberdeenshire
    Secrétaire
    56 Dawson Drive
    Skene
    AB32 6NS Westhill
    Aberdeenshire
    British123197880001
    PAULL & WILLIAMSONS
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    Secrétaire
    Union Plaza (6th Floor)
    1 Union Wynd
    AB10 1DQ Aberdeen
    24280001
    BURGESS, John Graham
    4 Willow Tree Way
    AB31 5JQ Banchory
    Aberdeenshire
    Administrateur
    4 Willow Tree Way
    AB31 5JQ Banchory
    Aberdeenshire
    BanchoryBritish37612260003
    COWIE, Julie Elizabeth
    5 Hartington Road
    AB10 6XT Aberdeen
    Aberdeenshire
    Administrateur
    5 Hartington Road
    AB10 6XT Aberdeen
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish111585570001
    FELTER, Peter Gjedboe, Dr
    Prince Hill House
    High Street, Worton
    SN10 5SE Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Prince Hill House
    High Street, Worton
    SN10 5SE Devizes
    Wiltshire
    UkDanish100602880001
    GILL, Bruce William
    22 Norman Gray Park
    AB21 0ZR Blackburn
    Aberdeenshire
    Administrateur
    22 Norman Gray Park
    AB21 0ZR Blackburn
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish118503010001
    HALL, Stuart
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    Administrateur
    Newlyn Huntly Road
    AB34 5HE Aboyne
    Aberdeenshire
    British37727490001
    MCINNES, Sandy
    Dunstaffnage
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    Administrateur
    Dunstaffnage
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    United KingdomBritish52989660002
    MCNIVEN, Alan Ross
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    Administrateur désigné
    Investment House 6 Union Row
    AB9 8DQ Aberdeen
    British900000280001

    SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Pledge over account
    Créé le 13 juin 2007
    Livré le 16 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The deposit in the account of £2,495,971.63.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juin 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 19 janv. 2007
    Livré le 01 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International
    Transactions
    • 01 févr. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 18 janv. 2007
    Livré le 24 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merrill Lynch International
    Transactions
    • 24 janv. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 17 févr. 2006
    Livré le 22 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 24 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of critical illness policy
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 20 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.1 the policy, all sums assured by it , and all bonuses and benefits, which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations), 1.2 the assignor's whole right, title and interest present and future in the policy.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Assignation of critical illness policy
    Créé le 13 déc. 2004
    Livré le 20 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.1 the policy, all sums assured by it and all bonuses and benefits, which may arise under it (including sundry conditions, provisions and declarations), 1.2 the assignors whole right, title and interest present and future in the policy,.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 févr. 1998
    Livré le 25 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 févr. 1998Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    SOVEREIGN FABRICATION SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 oct. 2011Administration ended
    25 févr. 2010Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John Bruce Cartwright
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh
    practitioner
    Erskine House
    68-73 Queen Street
    EH2 4NH Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0