SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC188598 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 107 George Street EH2 3ES Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mai 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation | |
|---|---|
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 18 août 2024 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2024 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Michael Joseph Maloco en tant que directeur le 27 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Kevin Mcluskey en tant que directeur le 27 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 août 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2023 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 août 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Bruce Spence en tant qu'administrateur le 01 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Ann Elizabeth Fleming en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2022 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Ben Daniel Cook en tant qu'administrateur le 01 janv. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2021 | 6 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alexander Ogilvie Pratt en tant que directeur le 30 nov. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Peter Ronald Rutherford Sturrock en tant qu'administrateur le 01 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2020 | 6 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Miss Ann Elizabeth Fleming le 17 déc. 2020 | 2 pages | CH01 | ||
Cessation de la nomination de Gordon John Kerr en tant que directeur le 24 nov. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 90a George Street Edinburgh EH2 3DF à 107 George Street Edinburgh EH2 3ES le 07 nov. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 18 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mai 2019 | 7 pages | AA | ||
Nomination de Ms Claire Louise Morgan en tant qu'administrateur le 26 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||
Qui sont les dirigeants de SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCE, Bruce | Secrétaire | 90a George Street EH2 3DF Edinburgh Midlothian | British | 105326800001 | ||||||
| COOK, Ben Daniel | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | United Kingdom | British | 225993700001 | |||||
| DIAMOND, Andrew Russell | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 172941410001 | |||||
| HILTON, Paul | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 237603210001 | |||||
| MORGAN, Claire Louise | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 264149610001 | |||||
| SPENCE, Bruce | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 303819130001 | |||||
| STURROCK, Peter Ronald Rutherford | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 278829110001 | |||||
| ANDERSON STRATHERN WS | Secrétaire | 1 Rutland Court EH3 8EY Edinburgh | 33516610002 | |||||||
| AIKEN, Peter David | Administrateur | Westwood Kings Road EH32 0NN Longniddry East Lothian | British | 1335570001 | ||||||
| BORROWMAN, David Haig | Administrateur | Elmbank Lovers Loan FK14 7AB Dollar Clackmannanshire | British | 116941900001 | ||||||
| BROWN, Scott Alexander | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | Scotland | Scottish | 80426870003 | |||||
| CALDER, Susan Jane | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | Scotland | British | 91161970001 | |||||
| CLARK, George Barrie | Administrateur | 7 Newbattle Terrace EH10 4RU Edinburgh | United Kingdom | British | 476120001 | |||||
| CLARK, James Graham | Administrateur | East Wing Laverockdale House 68 Dreghorn Loan EH13 0DB Edinburgh Midlothian | British | 817710001 | ||||||
| CUBIE, Andrew, Sir | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | United Kingdom | British | 11741100003 | |||||
| FLEMING, Ann Elizabeth | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 230533090002 | |||||
| FORSTER, Craig Mercer | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | Scotland | British | 157551260001 | |||||
| HARTLEY, Alan James | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | United Kingdom | British | 73024380001 | |||||
| HUNTER, Stewart Lindsay Wilson | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | Scotland | British | 65745580005 | |||||
| KERR, Gordon John | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 4668400001 | |||||
| KERR, John Neilson | Administrateur | 48 North Castle Street EH2 3LX Edinburgh Scotland | British | 65694070002 | ||||||
| LOUDON, Richard Donald | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | Scotland | British | 273830001 | |||||
| MALOCO, Michael Joseph | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 112727220001 | |||||
| MCLUSKEY, Kevin | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 253128050001 | |||||
| PATERSON, Dianne Elizabeth | Administrateur | 18 Clarendon Crescent EH4 1PU Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 81218360001 | |||||
| PEDDIE, Kyle Arthur David | Administrateur | 29 Hermitage Gardens EH10 6AZ Edinburgh | Scotland | British | 167470400001 | |||||
| PEDDIE, Pauline Dawn | Administrateur | 29 Hermitage Gardens EH10 6AZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 476160002 | |||||
| PRATT, Alexander Ogilvie | Administrateur | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 50940001 | |||||
| PRATT, John Anthony | Administrateur | Langdale Hall Melsonby DL10 5PW Richmond North Yorkshire | England | British | 71493270001 | |||||
| STIMPSON, Robin Mackay | Administrateur | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF | United Kingdom | British | 73898480002 | |||||
| URQUHART, Linda Hamilton | Administrateur | Kingarth 7 Pentland Avenue EH13 0HZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 108157980001 | |||||
| VALENTE, Philip Joseph John | Administrateur | 6 Lauder Road EH9 2EL Edinburgh | Scotland | British | 100405970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOLICITORS PROPERTY SHOPS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh Solicitors' Property Centre Limited | 06 avr. 2016 | George Street EH2 3DF Edinburgh 90a Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0