ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC190050 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Resolis Limited Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 28 oct. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 28 oct. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 28 oct. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1900500005 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1900500006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 20 pages | AA | ||
Nomination de Kirstine Jane Hyde en tant qu'administrateur le 04 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Adrian James Hill en tant que directeur le 30 sept. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Elliot Cardno Robertson en tant que directeur le 29 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Adrian James Hill en tant qu'administrateur le 29 mai 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr John Stephen Gordon en tant qu'administrateur le 29 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Peter Kenneth Johnstone en tant qu'administrateur le 29 janv. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de John Stephen Gordon en tant que directeur le 29 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 20 pages | AA | ||
Nomination de Mr John Stephen Gordon en tant qu'administrateur le 30 juin 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Peter Kenneth Johnstone en tant que directeur le 30 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022 | 19 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 08 oct. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Gary Martin Steven en tant que directeur le 28 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des détails de Robertson Health (New Craigs) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 avr. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de C/O Infrastructure Managers Limited 2nd Floor 11 Thistle Street Edinburgh EH2 1DF United Kingdom à C/O Resolis Limited Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EG le 08 avr. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Qui sont les dirigeants de ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLIS LIMITED | Secrétaire | 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh Exchange Tower, 11th Floor Scotland |
| 285489620001 | ||||||||||
| GORDON, John Stephen | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| HOLT, Robert Duncan | Administrateur | Baltic Place South Shore Road NE8 3AE Gateshead Floor 6 United Kingdom | England | British | 279257690001 | |||||||||
| HYDE, Kirstine Jane | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Scotland Scotland | Scotland | British | 328938770001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 53299620003 | |||||||||
| ROBERTSON, William George | Administrateur | Exchange Tower, 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Scotland | Scotland | British | 88810130001 | |||||||||
| BAND, James | Secrétaire | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House Stirlingshire Uk | 197376120001 | |||||||||||
| CLARK, Ian | Secrétaire | 1 Saint Peters Lane Duffus IV30 5WA Elgin Morayshire | British | 64044550002 | ||||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Secrétaire | 10 Perimeter Road Pinefield Industial Estate IV30 6AE Elgin Morayshire | British | 53299620002 | ||||||||||
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Secrétaire | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd Floor, 11 Midlothian United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| LYCIDAS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | 900003290001 | |||||||||||
| BAND, James Taylor | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House United Kingdom | United Kingdom | British | 214960480001 | |||||||||
| BRADLEY, Pauline Anne | Administrateur | Spruce Tree House By Gleneagles PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 122926460001 | ||||||||||
| BREE, Rhona Macdonald | Administrateur | Flat 3/2 64 Miller Street G1 1DT Glasgow Lanarkshire | British | 99563640001 | ||||||||||
| BURGE, Richard William Francis | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 114479400001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Administrateur | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 11 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 151812860001 | |||||||||
| DARLING, Andrew David | Administrateur | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | 73218540001 | ||||||||||
| FORDYCE, Alan Peter | Administrateur | 10 Perimeter Road Pinefield Industial Estate IV30 6AE Elgin Morayshire | Scotland | British | 97815240002 | |||||||||
| FORDYCE, Alan Peter | Administrateur | 10 Perimeter Road Pinefield Industial Estate IV30 6AE Elgin Morayshire | Scotland | British | 97815240002 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Dalmore Capital, Caledonian Exchange Scotland | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| HALLETT, Stephen John | Administrateur | Flat 17 Dunbar Wharf 108-124 Narrow Street E14 8BB London | United Kingdom | British | 94500430001 | |||||||||
| HILL, Adrian James | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House United Kingdom | United Kingdom | British | 323711220001 | |||||||||
| JOHNSTONE, Peter Kenneth | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 53299620003 | |||||||||
| MCDONAGH, John | Administrateur | 10 Perimeter Road Pinefield Industial Estate IV30 6AE Elgin Morayshire | United Kingdom | British | 182087330001 | |||||||||
| MCEWAN, Alastair John Angus | Administrateur | Melville Street EH3 7JF Edinburgh 35 City Of Edinburgh Scotland | Scotland | British | 171409910002 | |||||||||
| PERKS, John David George | Administrateur | 23 Braid Crescent EH10 6AX Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 885410001 | |||||||||
| RICHARDSON, Christopher Richard | Administrateur | Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 11 Scotland | United Kingdom | British | 258465700001 | |||||||||
| ROBERTSON, Elliot Cardno | Administrateur | Castle Business Park FK9 4TZ Stirling Robertson House United Kingdom | United Kingdom | British | 279252410001 | |||||||||
| SMITH, Martin Timothy | Administrateur | 9 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | Scotland | British | 82478070001 | |||||||||
| STEVEN, Gary Martin | Administrateur | 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Caledonian Exchange United Kingdom | United Kingdom | British | 209101460001 | |||||||||
| LYCIDAS NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | St. Vincent Street G2 5TQ Glasgow 292 | 900003280001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ROBERTSON HEALTH (NEW CRAIGS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robertson Health (New Craigs) Holdings Limited | 06 avr. 2016 | 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Exchange Tower Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0