3 ED HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | 3 ED HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC190329 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 25 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 11 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kenneth Andrew Mclellan le 28 janv. 2026 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2025 | 34 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Christopher Thomas Solley en tant que directeur le 31 janv. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Cameron Hannah Mclure en tant qu'administrateur le 31 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2024 | 38 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2023 | 36 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Rory William Christie en tant que directeur le 25 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Steven Mcghee en tant qu'administrateur le 25 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 11 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Thomas Solley le 08 août 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Rory William Christie le 01 janv. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Martin Timothy Smith le 08 août 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2022 | 36 pages | AA | ||
Changement d'adresse du siège social de 1 Atlantic Quay 1 Robertson Street Glasgow Scotland G2 8JB à Exchange Tower 19 Canning Street Edinburgh EH3 8EH le 24 juin 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 12 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2021 | 36 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kenneth Andrew Mclellan le 28 juil. 2021 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 13 nov. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2020 | 35 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 nov. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2019 | 32 pages | AA | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Stephen Gordon le 02 juil. 2019 | 2 pages | CH01 | ||
Qui sont les dirigeants de 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMPERIAN SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Secrétaire | 1 Gresham Street EC2V 7BX London 4th Floor United Kingdom |
| 107624260005 | ||||||||||
| GORDON, John Stephen | Administrateur | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| MCGHEE, Steven John | Administrateur | Caledonian Exchange, 2nd Floor 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalamore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 309598300001 | |||||||||
| MCLELLAN, Kenneth Andrew | Administrateur | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | Scotland | British | 110322970003 | |||||||||
| MCLURE, Cameron Hannah | Administrateur | George Street EH2 2LL Edinburgh 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 331818510001 | |||||||||
| RITCHIE, Alan Campbell | Administrateur | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148701690002 | |||||||||
| SMITH, Martin Timothy | Administrateur | St Andrew Square EH2 2AH Edinburgh 6 United Kingdom | Scotland | British | 82478070001 | |||||||||
| DONALDSON, Euan James | Secrétaire | 28 Trainers Brae EH39 4NR North Berwick East Lothian | British | 41273760002 | ||||||||||
| LEWIS, Maria | Secrétaire | Craighall Business Park 23 Eagle Street G4 9XA Glasgow Suite 1, Platinum House | British | 173226000001 | ||||||||||
| MACKINNON, Iain Lachlan | Secrétaire | 1 Hermitage Drive EH10 6DE Edinburgh | British | 66282570001 | ||||||||||
| MILLER, Roger Keith | Secrétaire | Kingsway WC2B 6AN London 1 United Kingdom | British | 120645920001 | ||||||||||
| SHELL, Peter Geoffrey | Secrétaire | 5 Kingsdale Road HP4 3BS Berkhamsted Hertfordshire | British | 75961450003 | ||||||||||
| SMYTH, Pamela June | Secrétaire | Hillside House Ecclesmachan EH52 6NG Broxburn West Lothian | British | 65057960001 | ||||||||||
| MACROBERTS - (FIRM) | Secrétaire désigné | 152 Bath Street G2 4TB Glasgow | 900018030001 | |||||||||||
| ANDERSON, Colin John | Administrateur | Atlantic Quay 1 Robertson Street G2 8JB Glasgow 1 Scotland | England | British | 223558780001 | |||||||||
| BLOOD, Gerard David | Administrateur | Flat 3 88 Greencroft Gardens NW6 3JQ London | Australian | 74828410001 | ||||||||||
| BREMNER, Alexander George | Administrateur | Inch Avenue Aberdour KY3 0TF Burntisland 3 Fife | Scotland | British | 152806580001 | |||||||||
| CHRISTIE, Rory William | Administrateur | EH3 7JF Edinburgh Dalmore Capital 35 Melville Street Scotland | United Kingdom | British | 183191460002 | |||||||||
| CONLON, Zaida Munshi | Administrateur | 1 Gresham Street EC2V 7BX London St Martins House | United Kingdom | British | 138673370003 | |||||||||
| CONLON, Zaida | Administrateur | 1 Gresham Street EC2V 7BX London St.Martins House | England | British | 138673370004 | |||||||||
| DARLING, Andrew David | Administrateur | 4 Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow West Lothian | British | 73218540001 | ||||||||||
| DONN, Michael Andrew | Administrateur | New Uberior House 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh 2nd Floor | United Kingdom | British | 108352120001 | |||||||||
| GETHIN, Ian Richard | Administrateur | 3 Lyncroft Gardens NW6 1LB London | Uk | British | 91224510002 | |||||||||
| GILLESPIE, Kenneth William | Administrateur | 7 Shaws Crescent EH26 0RE Milton Bridge Midlothian | Scotland | British | 105139700001 | |||||||||
| GRANT, Philip Robert | Administrateur | 40 Lumsdaine Drive KY11 9YU Dalgety Bay Fife | British | 76673520001 | ||||||||||
| HATZIS, Dimitrios | Administrateur | Cedar House Abingdon Road Tubney OX13 5QQ Oxford | United Kingdom | Greek | 117406500001 | |||||||||
| KELLY, Niven Charles Tait | Administrateur | 31 Grigor Avenue EH4 2PQ Edinburgh Midlothian | British | 522810001 | ||||||||||
| LINNEY, Joseph Mark | Administrateur | Atlantic Quay 1 Robertson Street G2 8JB Glasgow 1 Scotland Scotland | Scotland | British | 63161960001 | |||||||||
| MACDONALD, Iain Allan | Administrateur | 20 Trout Road GU27 1RD Haslemere Surrey | British | 73442300001 | ||||||||||
| MACKIE, Robin Smith | Administrateur | 4 Harburn Lane EH55 8BP West Calder West Lothian | British | 522870001 | ||||||||||
| MARSHALL, David Bruce | Administrateur | Brackens Heathdown Road Pyrford GU22 8LX Woking Surrey | England | British | 85602230002 | |||||||||
| MCEWAN, Michael William | Administrateur | 46 Learmonth Grove EH4 1BN Edinburgh | British | 59545340001 | ||||||||||
| MCINNES, Sarah Catherine | Administrateur | Atlantic Quay 1 Robertson Street G2 8JB Glasgow 1 Scotland | United Kingdom | British | 199622470001 | |||||||||
| MCLELLAN, Kenneth Andrew | Administrateur | Broad Quay House Prince Street BS1 4DJ Bristol Third Floor United Kingdom | Scotland | British | 110322970003 | |||||||||
| MCLELLAN, Kenneth | Administrateur | Flat 3/3 80 Monreith Road, Newlands G43 2PE Glasgow | Scotland | British | 110322970002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen Infrastructure (No.3) Limited | 06 avr. 2016 | Churchill Place E14 5HJ London 20 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Semperian Ppp Investment Partners No.2 Limited | 06 avr. 2016 | Gresham Street EC2V 7BX London Fourth Floor 1 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour 3 ED HOLDINGS LIMITED ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 11 nov. 2016 | 11 mai 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0