UBERIOR (GLASGOW) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | UBERIOR (GLASGOW) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC191167 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| Adresse du siège social | ATRIA ONE 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 juin 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 mars 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de The Mound Edinburgh EH1 1YZ United Kingdom à The Mound Edinburgh EH1 1YZ | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The Mound Edinburgh EH1 1YZ | 2 pages | AD03 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Mound Edinburgh EH1 1YZ à 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX le 04 févr. 2026 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital au 07 janv. 2026
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2024 au 30 juin 2025 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Alyson Elizabeth Mulholland le 12 mai 2025 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Neil Scott Burnett le 27 janv. 2025 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed stewart milne (glasgow) LIMITED\certificate issued on 09/05/24 | 2 pages | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 32 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Gerald Campbell More en tant que directeur le 19 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de Stewart Milne Homes (Southern) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 avr. 2024 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Grant Kirkhope en tant que directeur le 19 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Modification des détails de Horizon Capital 2000 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 avr. 2024 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 18 avr. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 18 avr. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MULHOLLAND, Alison Elizabeth | Secrétaire | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 319891000002 | |||||||||||
| BURNETT, Neil Scott | Administrateur | 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh New Uberior House United Kingdom | Scotland | British | 93937250005 | |||||||||
| DALY, Mark St John | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | England | British | 265216850001 | |||||||||
| BLACK, Lysanne Jane Warren | Secrétaire | 6 Belgrave Crescent EH4 3AQ Edinburgh | British | 46707740002 | ||||||||||
| EDWARDS, Laurence John | Secrétaire | Level2, 1 Lochrin Square 92 Fountainbridge EH3 9QA Edinburgh Lloyds Banking Group Scotland Scotland | British | 105476450001 | ||||||||||
| GITTINS, Paul | Secrétaire | Charterhall Drive CH88 3AN Chester Tower House United Kingdom | 204637330001 | |||||||||||
| HENNESSEY, David Dermot | Secrétaire | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 220597870001 | |||||||||||
| MACRAE, Alistair Ian | Secrétaire | 32 The Steils EH10 5XD Edinburgh Midlothian | British | 71950710001 | ||||||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secrétaire | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||||||
| LLOYDS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom |
| 73512200003 | ||||||||||
| ALLISON, Glenn Fraser Whyte | Administrateur | Linden Beeches 442 North Deeside Road AB15 9ET Cults Aberdeenshire | United Kingdom | British | 63687770002 | |||||||||
| ANDERSON, Bruce Smith | Administrateur | New Uberior House 11 Earl Grey Street EH3 9BN Edinburgh Lloyds Banking Group Scotland Scotland | Scotland | British | 73849040001 | |||||||||
| BARKLEY, John | Administrateur | 10 Willow Tree Place The Beeches EH14 5AZ Balerno Edinburgh, Midlothian | British | 18955940002 | ||||||||||
| BONE, Amy Charlotte | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 219208460001 | |||||||||
| COCHRANE, Gordon | Administrateur | Beaconhill Den AB13 0HT Milltimber Aberdeen | Scotland | British | 545540005 | |||||||||
| COLLINS, Aubrey Mark | Administrateur | 1st Floor East Tower House, Charterhall Drive CH88 3AN Chester Lloyds Banking Group England | England | British | 146892050001 | |||||||||
| CRAWFORD, Douglas James | Administrateur | 37 The Steils EH10 5XD Edinburgh | British | 55793670001 | ||||||||||
| CRUICKSHANK, James Kerr | Administrateur | 3 Mid Steil Glenlockhart EH10 5XB Edinburgh Midlothian | British | 46894940001 | ||||||||||
| DE VRIES, Monica Marian | Administrateur | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 267979030003 | |||||||||
| GIBSON, Fiona Jane | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 199628530002 | |||||||||
| HARRIES, Paul Ronayne | Administrateur | 1st Floor East Tower House, Charterhall Drive CH88 3AN Chester Lloyds Banking Group England | United Kingdom | British | 73866740002 | |||||||||
| HEWITT, Alistair James Neil | Administrateur | St Vincent Street G2 5ER Glasgow 110 United Kingdom | Scotland | British | 113081830001 | |||||||||
| HULME, Andrew | Administrateur | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | United Kingdom | British | 184775990002 | |||||||||
| KIRKHOPE, Grant | Administrateur | 3 Kilmartin Place Tannochside Business Park G71 5PH Uddingston Kestrel House United Kingdom | United Kingdom | British | 272470730001 | |||||||||
| LOUDON, Gavin Cameron | Administrateur | 37 Craigmillar Avenue Milngavie G62 8AX Glasgow Strathclyde | Scotland | British | 72871180001 | |||||||||
| MORE, Gerald Campbell | Administrateur | Westhill Business Park Westhill AB32 6JQ Aberdeen Peregrine House Scotland | Scotland | British | 211208700001 | |||||||||
| ONEIL, James Charles | Administrateur | c/o Level 1 Citymark Fountainbridge EH3 9PE Edinburgh 150 | British | 63521290001 | ||||||||||
| POLSON, Michael Buchanan | Administrateur | 11 Craighall Gardens EH6 4RH Edinburgh | British | 46168760001 | ||||||||||
| WILSON, Andrew William John | Administrateur | 1 Suffolk Lane EC4R 0AX London Princess House England England | United Kingdom | British | 170653990001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UBERIOR (GLASGOW) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stewart Milne Homes (Southern) Limited | 06 avr. 2016 | Mosscroft Avenue Westhill Business Park AB32 6TQ Aberdeen Peregrine House Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Horizon Capital 2000 Limited | 06 avr. 2016 | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
UBERIOR (GLASGOW) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0