PCG RESIDENTIAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPCG RESIDENTIAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC192250
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor 115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FIBRERUSK LIMITED30 déc. 199830 déc. 1998

    Quels sont les derniers comptes de PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Terrace Hill (Secretaries) Limited le 28 oct. 2015

    1 pagesCH04

    État du capital au 17 sept. 2015

    • Capital: GBP 1.00
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    legacy

    1 pagesSH20

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2014

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Martin Austen le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip Alexander Jeremy Leech le 08 juin 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2013

    12 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 24 Great King Street Edinburgh EH3 6QN* le 23 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 janv. 2014

    État du capital au 03 janv. 2014

    • Capital: GBP 200,000
    SH01

    Cessation de la nomination de Thomas Walsh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Alexander Jeremy Leech en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Jonathan Martin Austen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Miranda Kelly en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG03s

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    12 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Qui sont les dirigeants de PCG RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    URBAN&CIVIC (SECRETARIES) LIMITED
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    115 George Street
    EH2 4JN Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC154216
    41006000014
    AUSTEN, Jonathan Martin
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish51921200001
    LEECH, Philip Alexander Jeremy
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    Administrateur
    W1S 1BJ London
    50 New Bond Street
    United Kingdom
    EnglandBritish77080490002
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CUFLEY, Sean Dominic Hardy
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    Bank Cottage Haywards Heath Road
    Balcombe
    RH17 6NF Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish9150920001
    GORDON, Alastair James
    Pitfar Lodge
    Powmill
    FK14 7NS Dollar
    Clackmannanshire
    Administrateur
    Pitfar Lodge
    Powmill
    FK14 7NS Dollar
    Clackmannanshire
    British35967420001
    HOBBS, David William Raymond
    Darenth
    Vicarage Hill
    TN16 1TL Westerham
    Kent
    Administrateur
    Darenth
    Vicarage Hill
    TN16 1TL Westerham
    Kent
    British58875030001
    KELLY, Miranda Anne
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    Administrateur
    21 Rozelle Avenue
    Waterside, Newton Mearns
    G77 6YS Glasgow
    ScotlandBritish62817160003
    MACDONALD, Donald Ross
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    Administrateur
    Flat 2r, 37 Bellshaugh Gardens
    Kelvinside
    G12 0SA Glasgow
    United KingdomBritish76786510001
    ROBINSON, Alasdair Nicholson
    18 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    Administrateur
    18 Rosslyn Terrace
    Dowanhill
    G12 9NA Glasgow
    British62432130001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Administrateur
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    EnglandIrish48520230001
    WILSON, Alistair Barclay
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Cauldstream Place
    Milngavie
    G62 7NL Glasgow
    Lanarkshire
    British426640001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    PCG RESIDENTIAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 20 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat 4, 43 kent road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 20 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat at 4 shieldhall gardens, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 mars 2002
    Livré le 03 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flat at 1/m, 280 st. George's road, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 avr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 29 oct. 2001
    Livré le 07 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 oct. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Créé le 27 nov. 2000
    Livré le 30 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 30 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 184, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 179, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 176, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking 159, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 104, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 101, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 99, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 13, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over parking space 8, granby village, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 31 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 30 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 20 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 19 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 18 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 16 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 14 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 11 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 10 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 9 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 11 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 7 venice court, samuel ogden street, manchester fixed charge over assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0