GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC193483
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Argyll Court
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Scotland
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GLADEDALE (EAST SCOTLAND) LIMITED25 juil. 200825 juil. 2008
    GLADEDALE (PARTNERSHIPS) LTD25 janv. 200725 janv. 2007
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED26 mai 200526 mai 2005
    BETT HOMES (NORTH EAST SCOTLAND) LIMITED27 avr. 200527 avr. 2005
    BETT PARTNERSHIPS LIMITED18 mars 199918 mars 1999
    MITRESHELF 253 LIMITED16 févr. 199916 févr. 1999

    Quels sont les derniers comptes de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2016

    28 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 nov. 2016

    État du capital au 01 nov. 2016

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Demande de rétablissement administratif

    3 pagesRT01

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2015 au 30 avr. 2016

    1 pagesAA01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Edward Lewis le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Giles Henry Sharp le 22 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Joanne Elizabeth Massey le 22 oct. 2015

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de Regency House Crossgates Road, Halbeath Dunfermline, Fife KY11 7EG à Argyll Court the Castle Business Park Stirling Scotland FK9 4TT le 23 oct. 2015

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jon William Mortimore en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mars 2015

    État du capital au 06 mars 2015

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Giles Sharp en tant qu'administrateur le 23 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Neil Fitzsimmons en tant que directeur le 12 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Secrétaire
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    147808920001
    LEWIS, Colin Edward
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    WalesWelsh59395180001
    SHARP, Giles Henry
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    Administrateur
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Scotland
    United KingdomBritish194659450001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secrétaire
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie-Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    Secrétaire
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Angus
    British606150011
    BISHOP & ROBERTSON CHALMERS
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    Secrétaire désigné
    2 Blythswood Square
    G2 4AD Glasgow
    900003620001
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    BAIRD, Ian Coid
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    Administrateur
    13 Hatton View
    PH2 7DA Perth
    ScotlandBritish44063980001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Administrateur
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritish79873860001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Administrateur
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Administrateur
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Administrateur
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritish91229410003
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Administrateur
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    35
    Lanarkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish102797820001
    LANG, James Russell
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    Administrateur désigné
    Flat 3f Melbourne Court
    Braid Park Drive Giffnock
    Glasgow
    British900003610001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    MACCOLL, Stuart Neil
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    Administrateur
    47 Murieston Valley
    Murieston
    EH54 9HJ Livingston
    West Lothian
    ScotlandBritish111800560001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Administrateur
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MILLAR, James Allan
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    Administrateur désigné
    Laggan House
    Campsie Dene Road Blanefield
    Glasgow
    British900003600001
    MORTIMORE, Jon William
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Administrateur
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish207729000002
    RIDDLE, Andrew
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    Administrateur
    5 Clune Road
    KY12 9NZ Gowkhall
    Fife
    British117037490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    06 avr. 2016
    The Castle Business Park
    FK9 4TT Stirling
    Argyll Court
    Scotland
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementScotland
    Autorité légaleUnited Kingdom (Scotland)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrementSc024489
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GLADEDALE PARTNERSHIPS (SCOTLAND) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 14 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 14 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 30 déc. 2008
    Livré le 08 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 janv. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 28 févr. 2005
    Livré le 10 mars 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Land at north-west side of glasgow road, dennyloanhead (title number stg 50880).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 21 nov. 2003
    Livré le 28 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due pursuant to the personal bond dated 20 may 2003
    Brèves mentions
    6.12 acres at greenhill road, bonnybridge, county of stirling.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5.98 acres at greenhill road, bonnybridge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 23 mai 2003
    Livré le 30 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    3.769 hectares at harrysmuir road, houston industrial estate, livingston.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 21 mai 2003
    Livré le 03 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 03 juin 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 28 mars 2001
    Livré le 04 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Heritable property at whitehill sidings, whitehill road, hamilton, lanarkshire.
    Personnes ayant droit
    • Scottish Homes
    Transactions
    • 04 avr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0