GLASGOW HARBOUR LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLASGOW HARBOUR LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC193933 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| Adresse du siège social | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 mars 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 18 mars 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 04 mars 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Matthew Paul Colton en tant que directeur le 15 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2025 | 15 pages | AA | ||
legacy | 66 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
Nomination de Christopher Eves en tant qu'administrateur le 19 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr John Peter Whittaker en tant qu'administrateur le 19 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Inscription de la charge SC1939330081, créée le 24 avr. 2025 | 14 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1939330084, créée le 15 avr. 2025 | 23 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1939330085, créée le 15 avr. 2025 | 25 pages | MR01 | ||
Modifications à la charge flottante SC1939330079 | 26 pages | 466(Scot) | ||
Inscription de la charge SC1939330082, créée le 15 avr. 2025 | 52 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1939330083, créée le 15 avr. 2025 | 33 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1939330079, créée le 15 avr. 2025 | 16 pages | MR01 | ||
Inscription de la charge SC1939330080, créée le 15 avr. 2025 | 18 pages | MR01 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330078 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330072 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330074 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330067 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330064 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330065 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330070 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330073 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330077 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Satisfaction de la charge SC1939330069 en totalité | 4 pages | MR04 | ||
Qui sont les dirigeants de GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVES, Christopher | Administrateur | Ballnahowe IM9 6JF Port Erin Ballaman Isle Of Man | Isle Of Man | British | 302666620001 | |||||
| UNDERWOOD, Steven Keith | Administrateur | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building England | United Kingdom | British | 162134250001 | |||||
| WHITTAKER, James | Administrateur | 1 Old Park Lane Urmston M41 7HA Manchester Venus Building England | United Kingdom | British | 114981140001 | |||||
| WHITTAKER, John Peter | Administrateur | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire | United Kingdom | British | 200357190001 | |||||
| WHITTAKER, John | Administrateur | Ballnahowe IM9 6JF Port Erin Ballaman Isle Of Man | Isle Of Man | British | 1614010014 | |||||
| WHITWORTH, Mark | Administrateur | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire | United Kingdom | British | 308904160001 | |||||
| GREEN, David Simon | Secrétaire | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | 42038120003 | ||||||
| LEES, Neil | Secrétaire | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | British | 29912450002 | ||||||
| SEMPLE, Mitchell Scott | Secrétaire | Bonnyton Cottage Eaglesham G76 0PY Glasgow Lanarkshire | British | 365320001 | ||||||
| BLP SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005150001 | |||||||
| ALLISON, Thomas Eardley | Administrateur | Rockdale Lodge 23 Park Place FK7 9JR Stirling Scotland | Scotland | British | 1037730004 | |||||
| COLTON, Matthew Paul | Administrateur | 16 Robertson Street Glasgow G2 8DS Lanarkshire | United Kingdom | British | 311987450001 | |||||
| CUMMINGS, Peter Joseph | Administrateur | Glen View 6 Barloan Crescent G82 2AT Dumbarton Dunbartonshire | Scotland | British | 68241910003 | |||||
| GREEN, David Simon | Administrateur | 16a Inverleith Row EH3 5LS Edinburgh | British | 42038120003 | ||||||
| HOSKER, Peter John | Administrateur | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | United Kingdom | British | 156229430001 | |||||
| JAMIESON, Euan | Administrateur | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | United Kingdom | British | 53358690001 | |||||
| JONAS, Christopher William | Administrateur | 25 Victoria Square SW1W 0BB London | England | British | 122619820001 | |||||
| LEES, Neil | Administrateur | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | United Kingdom | British | 29912450006 | |||||
| LESLIE, Colin David | Administrateur | 12 Viewbank View EH19 2HU Bonnyrigg Midlothian | British | 1358070001 | ||||||
| MITCHELL, George Edward | Administrateur | 4b Essex Road EH4 6LE Edinburgh | Scotland | British | 985140002 | |||||
| MOORE, Gordon | Administrateur | 20 Cairnhill Road Bearsden G61 1AU Glasgow Lanarkshire | British | 65092990001 | ||||||
| SCHOFIELD, John Alexander | Administrateur | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building England | United Kingdom | British | 103613040002 | |||||
| SCOTT, Peter Anthony | Administrateur | 6 Bowling Green Way Bamford OL11 5QQ Rochdale Lancashire | British | 1674500002 | ||||||
| SIMPSON, Andrew Christopher | Administrateur | Park Road WA15 9NN Hale 24 Cheshire United Kingdom | England | British | 112776340002 | |||||
| WAINSCOTT, Paul Philip | Administrateur | The Trafford Centre M17 8PL Manchester Peel Dome England England | United Kingdom | British | 1549660002 | |||||
| BLP CREATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005130001 | |||||||
| BLP FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 130 St Vincent Street G2 5HF Glasgow Strathclyde | 900005140001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GLASGOW HARBOUR LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peel L&P Property Intermediate Limited | 18 août 2016 | 1 Old Park Lane Traffordcity M41 7HA Manchester Venus Building United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Peel Holdings (Glasgow Harbour) Limited | 06 avr. 2016 | Intu Trafford Centre Traffordcity M17 8PL Manchester Peel Dome United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0