THE NEW YORKER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTHE NEW YORKER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC194403
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de THE NEW YORKER LIMITED ?

    • (9234) /

    Où se situe THE NEW YORKER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O ERNST & YOUNG LLP
    George House 50 George Squre
    G2 1RP Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de THE NEW YORKER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour THE NEW YORKER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de passage de l'administration à la dissolution

    8 pages2.26B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    16 pages2.20B(Scot)

    Proposition de l'administrateur

    62 pages2.16B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.11B(Scot)

    legacy

    1 pages287

    Résolutions

    Resolutions
    10 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Enter into floating charge 23/01/2009
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    legacy

    3 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 11

    11 pages466(Scot)

    legacy

    7 pages410(Scot)

    legacy

    15 pages410(Scot)

    Modifications à la charge flottante 7

    11 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 9

    11 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 8

    11 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante 10

    11 pages466(Scot)

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages419a(Scot)

    Qui sont les dirigeants de THE NEW YORKER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RODRIGUES, Karen
    35 Harford Drive
    WD17 3DQ Watford
    Hertfordshire
    Secrétaire
    35 Harford Drive
    WD17 3DQ Watford
    Hertfordshire
    British80711380002
    KELLY, Maurice William
    91 Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Orchard Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    91 Bishopstone
    HP17 8SH Aylesbury
    Orchard Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director131922310001
    LANGLEY, Sean Jonathan
    Steeplefield
    SS9 5XJ Leigh-On-Sea
    87
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Steeplefield
    SS9 5XJ Leigh-On-Sea
    87
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishMarketing Director128068590001
    RODRIGUES, Karen
    35 Harford Drive
    WD17 3DQ Watford
    Hertfordshire
    Administrateur
    35 Harford Drive
    WD17 3DQ Watford
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director80711380002
    CORTELLESSA, Gennaro
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector64309410001
    SMITH, Peter Anthony
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    Secrétaire
    Forge Cottage
    Forge Lane, Shorne
    DA12 3DP Gravesend
    Kent
    BritishCompany Secretary71842080001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    COLLINS, Peter John
    Hawthornes
    Harbidges Lane
    NN6 7QL Long Buckby
    Northamptonshire
    Administrateur
    Hawthornes
    Harbidges Lane
    NN6 7QL Long Buckby
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector84320770001
    CORTELLESSA, Gennaro
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector64309410001
    CORTELLESSA, Giovanni Battista
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    Administrateur
    79 Colinton Road
    EH10 5DF Edinburgh
    ScotlandItalianProperty Developer142685800001
    HASPEL, Peter William
    22 Bushnell Road
    SW17 8QP London
    Administrateur
    22 Bushnell Road
    SW17 8QP London
    EnglandBritishManaging Director96525010001
    PREW, Simon Barry
    11 Nomansland Common
    Wheathampstead
    AL4 8EJ St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    11 Nomansland Common
    Wheathampstead
    AL4 8EJ St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishFinance Director117277860001
    REID, Christopher John
    Hawthorn Crescent
    Burbage
    LE10 2JP Hinckley
    41
    Leicestershire
    England
    Administrateur
    Hawthorn Crescent
    Burbage
    LE10 2JP Hinckley
    41
    Leicestershire
    England
    EnglandBritishCommercial Director133910590001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    THE NEW YORKER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenure
    Créé le 23 janv. 2009
    Livré le 09 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 févr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 23 janv. 2009
    Livré le 06 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rileys Acquisitions Limited
    Transactions
    • 06 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 févr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 23 janv. 2009
    Livré le 06 févr. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rileys Acquisitions Limited
    Transactions
    • 06 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 févr. 2009Enregistrement d'une charge (410)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Debenture
    Créé le 28 août 2007
    Livré le 13 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Composite debenture including legal mortgage, fixed charges and floating charge - see form 410 paper apart for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 13 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 févr. 2009
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 28 août 2007
    Livré le 13 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transactions
    • 13 sept. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 févr. 2009Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See form 410 paper apart, contains fixed charges, legal mortgage and floating charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mars 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    See form 410 paper apart, contains fixed charges, legal mortgage and floating charge.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mars 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mars 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 16 févr. 2007
    Livré le 05 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 mars 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 mars 2007Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 22 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 29 nov. 1999
    Livré le 07 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ainslie house, 11 st colme street, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 déc. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 14 oct. 1999
    Livré le 25 oct. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 oct. 1999Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    THE NEW YORKER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 mars 2010Administration ended
    25 mars 2009Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0