TURNING POINT SCOTLAND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTURNING POINT SCOTLAND
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC194639
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TURNING POINT SCOTLAND ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale
    • Autres activités de soins résidentiels n.c.a. (87900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe TURNING POINT SCOTLAND ?

    Adresse du siège social
    Merchants House
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TURNING POINT SCOTLAND ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TURNING POINT SCOTLAND ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation08 avr. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au25 mars 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour TURNING POINT SCOTLAND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Satisfaction de la charge 17 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 16 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2025

    62 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Patricia Anne Cassidy le 25 mars 2025

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Louise Smith en tant que directeur le 19 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2024

    59 pagesAA

    Nomination de Miss Fiona Jane Walker en tant qu'administrateur le 10 mai 2024

    2 pagesAP01

    Statuts

    22 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Louise Smith le 25 mars 2024

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modifications à la charge flottante SC1946390023

    14 pages466(Scot)

    Modifications à la charge flottante SC1946390022

    14 pages466(Scot)

    Inscription de la charge SC1946390023, créée le 16 oct. 2023

    17 pagesMR01

    Inscription de la charge SC1946390022, créée le 09 oct. 2023

    23 pagesMR01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2023

    58 pagesAA

    Nomination de Mr Allan James Clow en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Paul Mcauslan en tant que directeur le 12 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Murray Stuart Husband en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alexander Douglas Mclaren en tant qu'administrateur le 01 sept. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gary William Brewer en tant que directeur le 01 juil. 2023

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 18 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 25 mars 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de TURNING POINT SCOTLAND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TC YOUNG LLP
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Secrétaire
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Forme juridiqueLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleLIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS ACT 2000
    Numéro d'enregistrementSO302634
    92309420007
    BUNCE, Alison
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish246941880001
    CASSIDY, Patricia Anne
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish287067570001
    CLOW, Allan James
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish183442130001
    COOK, Graeme James
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish251910880001
    GABBITAS, Peter
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish199332360001
    GIBBS, Kathryn Lorna
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish260306630001
    HUSBAND, Murray Stuart
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish192291560001
    MAZZUCCO, Marc Paul
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    United KingdomBritish287067200001
    MCLAREN, Alexander Douglas
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish261911830001
    PLUMMER, Stephen Philip
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish164301050001
    THOMSON, Jennifer
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish292103450001
    WALKER, Fiona Jane
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish286551590001
    ABRAHAM, Estella Emily
    The Sheiling
    Eshiels
    EH45 8NA Peebles
    Administrateur
    The Sheiling
    Eshiels
    EH45 8NA Peebles
    ScotlandBritish91059250002
    ALEXANDER, Morag
    Achomraich Dull
    PH15 2JQ Aberfeldy
    Perthshire
    Administrateur
    Achomraich Dull
    PH15 2JQ Aberfeldy
    Perthshire
    British76313720007
    ALLAN, Callum Macphail
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish1285600001
    ARTACHO, Morgane
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandFrench136827650002
    BELL, Graham Mcneil
    An Claggan Argyll Road
    Kilcreggan
    G84 0HU Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    An Claggan Argyll Road
    Kilcreggan
    G84 0HU Helensburgh
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish43237490001
    BOYD, Lesley Jane
    11a Albert Terrace
    EH10 5EA Edinburgh
    Administrateur
    11a Albert Terrace
    EH10 5EA Edinburgh
    ScotlandBritish41253890003
    BREWER, Gary William
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish292105290001
    CAMERON, Thomas Anthony
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish130652200002
    EDWARDS, Raymond
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish108753780002
    FAZAL, Sheila Elizabeth
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish160863230001
    FINDLAY, Craig William
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish154496110001
    GILDER, Paula Margaret
    4 London Street
    EH3 6NA Edinburgh
    Administrateur
    4 London Street
    EH3 6NA Edinburgh
    British63151590001
    GRAY, Elizabeth Wood
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandScottish137670260002
    HAMILTON, Lindsay
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    United KingdomBritish116378730001
    HAMILTON, Peter Farmer
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Scotland
    ScotlandBritish160864280001
    HILL, Iain Burns
    92 Hyndland Road
    G12 9PZ Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    92 Hyndland Road
    G12 9PZ Glasgow
    Strathclyde
    British40902170001
    HOWELL, Keith Martin
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    Administrateur
    Govan Road
    G51 1JL Glasgow
    54
    Scotland
    ScotlandBritish1499960007
    HOWELL, Keith Martin
    White Moss
    EH46 7BS West Linton
    Peeblesshire
    Administrateur
    White Moss
    EH46 7BS West Linton
    Peeblesshire
    ScotlandBritish1499960007
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Administrateur
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    British1499960006
    HUGHES, Joseph Christopher
    Ashgrove House
    3 St Andrews Avenue
    G71 8DN Bothwell
    Administrateur
    Ashgrove House
    3 St Andrews Avenue
    G71 8DN Bothwell
    ScotlandBritish297812020001
    ILLSLEY, Judith
    64 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    Administrateur
    64 Lauderdale Gardens
    G12 9QW Glasgow
    British108753720001
    JAGPAL, Daradjeet
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    Administrateur
    7 West George Street
    G2 1BA Glasgow
    Merchants House
    ScotlandBritish212716220001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TURNING POINT SCOTLAND ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    25 mars 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0