NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED

NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC196860
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Cunninghame House
    Friars Croft
    KA12 8EE Irvine
    Ayrshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PACIFIC SHELF 862 LIMITED04 juin 199904 juin 1999

    Quels sont les derniers comptes de NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 juil. 2014

    État du capital au 01 juil. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * Perceton House Perceton Irvine Ayrshire KA11 2DE* le 01 juil. 2014

    1 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Dolphin House 4 Hunter Square Edinburgh EH1 1QW Scotland

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Eric Adair en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Nomination de Ms Marie Agnes Burns en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David O'neill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01s

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Nomination de Laura Friel en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alasdair Herbert en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Eric Weir Adair le 04 juin 2010

    2 pagesCH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Hunter le 04 juin 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURNS, Marie Agnes, Councillor
    Friars Croft
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    Friars Croft
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayrshire
    Scotland
    ScotlandBritish163290600001
    FRIEL, Laura
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayr
    Administrateur
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    Ayr
    ScotlandScottish164354140001
    HUNTER, John
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    ScotlandBritish122240740001
    MURRAY, Elizabeth Margaret
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    North Ayrshire
    Administrateur
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame House
    North Ayrshire
    ScotlandBritish151877610001
    MCGOWAN, Carol Ann
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    374 Leith Walk
    EH7 4PE Edinburgh
    Midlothian
    British112664200001
    WILSON, Mary
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    Secrétaire
    3 Belgrave Road
    EH12 6NG Edinburgh
    British42188180001
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    ADAIR, Eric Weir
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Dolphin House
    Scotland
    Administrateur
    4 Hunter Square
    EH1 1QW Edinburgh
    Dolphin House
    Scotland
    ScotlandBritish116185430001
    BRADBURY, Neil
    29/8 Fettes Row
    EH3 6RL Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    29/8 Fettes Row
    EH3 6RL Edinburgh
    Midlothian
    British61163630002
    DI CIACCA, John Mark
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    Administrateur
    Jaytu
    Main Road
    KY11 1HA North Queensferry
    Fife
    United KingdomBritish77111830002
    HERBERT, Alasdair James
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    ScotlandBritish66562580001
    HUNTER, Colin Ian
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    Administrateur
    Stonelaws Farm
    EH40 3DX East Linton
    East Lothian
    ScotlandBritish37329910003
    JOHNSON, Neil Scott
    2 Eweford Cottages
    EH42 1RF Dunbar
    Administrateur
    2 Eweford Cottages
    EH42 1RF Dunbar
    British72927080004
    MACDONALD, Brian
    Bentinck Drive
    KA10 6HY Troon
    52
    Ayrshire
    Administrateur
    Bentinck Drive
    KA10 6HY Troon
    52
    Ayrshire
    ScotlandBritish59955550001
    MUNN, David Robert
    2 Hogarth Avenue
    KA21 6BY Saltcoats
    Ayrshire
    Administrateur
    2 Hogarth Avenue
    KA21 6BY Saltcoats
    Ayrshire
    British22230020001
    O'NEILL, David John Brian
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    House
    KA12 8EE Irvine
    Cunninghame
    Ayrshire
    Scotland
    United KingdomBritish39193070001
    RAE, Colin Kenneth
    5 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    Administrateur
    5 Blinkbonny Grove
    EH4 3HH Edinburgh
    British36835530002
    SMART, Jeremy John
    24 Darnley Gardens
    Pollokshields
    G41 4NG Glasgow
    1/2
    Scotland
    Administrateur
    24 Darnley Gardens
    Pollokshields
    G41 4NG Glasgow
    1/2
    Scotland
    United KingdomBritish140155680001
    SNODGRASS, Ian Thomas
    7 Charles Drive
    KA10 7AG Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    7 Charles Drive
    KA10 7AG Troon
    Ayrshire
    British77975530002
    SUTHERLAND, Duncan
    Whitefold Farmhouse
    Four Acre Lane
    PR3 2TD Thornley
    Lancashire
    Administrateur
    Whitefold Farmhouse
    Four Acre Lane
    PR3 2TD Thornley
    Lancashire
    EnglandBritish78226760001
    WALL, Ian James, Prof
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    85 Warrender Park Road
    EH9 1EW Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish430300001
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    NORTH AYRSHIRE VENTURES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 02 mai 2012
    Livré le 04 mai 2012
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects forming area of ground extending to 5.310 square metres lying to the north east of glencairn street in the east end of the town of saltcoats, title number AYR24389 and the subjects on the east side of pennyburn road, kilwinning, ayrshire, title number AYR58509.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 2012Enregistrement d'une charge (MG01s)
    Standard security
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 18 févr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Subjects on the east side of pennyburn road, kilwinning, ayrshire AYR58509.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 18 févr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 févr. 2004
    Livré le 24 févr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    55.7% pro indiviso share of rennie business units, mcisaac road/factory place, saltcoats AYR26810.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 11 févr. 2004
    Livré le 24 févr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    44.3% pro indiviso share of bennie business units, mcisaac road/factory place, saltcoats AYR026810.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 21 févr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground extending to 5.310 square metres lying to the north east of glencairn street in the east end of the town of saltcoats.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0