SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND

SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC197327
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    Adresse du siège social
    196 Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 juil. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au18 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mr Adrian Harkin en tant qu'administrateur le 06 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Maureen Louise Rooney en tant qu'administrateur le 06 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Marion Elizabeth Everett en tant que secrétaire le 30 janv. 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de J. Mcsparran and Mccormick en tant que secrétaire le 30 janv. 2025

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Alison Frances O'connell en tant qu'administrateur le 26 juin 2024

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    37 pagesAA

    Cessation de la nomination de Joseph Christopher Hughes en tant que directeur le 23 juin 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 7 West Nile Street Glasgow G1 2PR Scotland à 196 Clyde Street Glasgow G1 4JY le 18 avr. 2024

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Therese Mema Mapenzi en tant que directeur le 21 sept. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    40 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Canon Michael Hutson en tant qu'administrateur le 24 mai 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Keenan en tant que directeur le 27 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Leo William Cushley en tant que directeur le 27 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Statuts

    23 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Diane Burke en tant qu'administrateur le 16 juin 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Joseph Christopher Hughes en tant qu'administrateur le 16 juin 2022

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2021

    41 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Michael Anthony Gerard Mannion en tant que directeur le 16 juin 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Daniel Gallagher en tant que directeur le 16 juin 2022

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    40 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVERETT, Marion Elizabeth
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Secrétaire
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    331997760001
    BURKE, Diane
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishCommercial Director297822520001
    HARKIN, Adrian
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishProject Officer286718130001
    HUTSON, Michael, Canon
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishCatholic Priest309771660001
    MCGEE, Brian Thomas, Bishop
    Corran Esplanade
    PA34 5AB Oban
    Bishop's House
    United Kingdom
    Administrateur
    Corran Esplanade
    PA34 5AB Oban
    Bishop's House
    United Kingdom
    ScotlandScottishRoman Catholic Bishop Of Argyll & The Isles209814210001
    MCMILLAN, Lorraine Anne
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishChief Executive, East Renfrewshire Council33802670002
    NOLAN, William, Bishop
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishBishop242855270001
    O'CONNELL, Alison Frances
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishCivil Servant325151110001
    ROONEY, Maureen Louise
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishCivil Servant308644630001
    TOAL, Joseph Anthony, The Right Reverend
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishBishop166567250001
    J. MCSPARRAN AND MCCORMICK
    19
    Waterloo Street
    G2 6AH Glasgow
    Waterloo Chambers
    Lanarkshire
    Secrétaire
    19
    Waterloo Street
    G2 6AH Glasgow
    Waterloo Chambers
    Lanarkshire
    Forme juridiquePARTNERSHIP
    Type d'identificationAutre personne morale ou société
    Autorité légaleUK WIDE
    64565510001
    CARDINAL O'BRIEN, Keith Patrick, Most Reverend
    42 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    42 Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritishArchbis./ St Andrews/Edinburgh419420001
    CARDINAL WINNING, Thomas Joseph, Most Reverend
    40 Newlands Road
    G43 2JD Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    40 Newlands Road
    G43 2JD Glasgow
    Lanarkshire
    BritishArchbishop Of Glasgow419410001
    CONTI, Mario Joseph, Most Reverend
    40 Newlands Road
    G43 2JD Glasgow
    Strathclyde
    Administrateur
    40 Newlands Road
    G43 2JD Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritishBishop80979730001
    CUSHLEY, Leo William, Archbishop
    Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    42
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Gardens
    EH10 4BJ Edinburgh
    42
    Scotland
    ScotlandBritishArchbishop183695800001
    GALLAGHER, James Daniel
    Milton Crescent
    EH15 3PQ Edinburgh
    54
    Scotland
    Administrateur
    Milton Crescent
    EH15 3PQ Edinburgh
    54
    Scotland
    ScotlandBritishAcademic, Company Director61976840001
    HUGHES, Joseph Christopher
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    Administrateur
    Clyde Street
    G1 4JY Glasgow
    196
    Scotland
    ScotlandBritishCompany Director297812020001
    KEENAN, John, Bishop
    West Nile Street
    G1 2PR Glasgow
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Nile Street
    G1 2PR Glasgow
    7
    Scotland
    ScotlandBritishRoman Catholic Bishop229202350001
    MACLAREN, Duncan Macgregor
    Montrose Street
    Flat 14
    G1 1RE Glasgow
    20
    Scotland
    Administrateur
    Montrose Street
    Flat 14
    G1 1RE Glasgow
    20
    Scotland
    ScotlandBritishAdjunct Professor/Consultant/Phd Student190619160001
    MANNION, Michael Anthony Gerard
    Beechwood Drive
    G11 7DX Glasgow
    150
    Scotland
    Administrateur
    Beechwood Drive
    G11 7DX Glasgow
    150
    Scotland
    ScotlandBritishUniversity Vice-Principal161154770001
    MAPENZI, Therese Mema
    West Nile Street
    G1 2PR Glasgow
    7
    Scotland
    Administrateur
    West Nile Street
    G1 2PR Glasgow
    7
    Scotland
    Congo, The Democratic Republic Of TheCongolese (Drc)Pastoral Agent, Director Of Centre Olame Bukavu281806100001
    MONE, John, The Right Rev
    Carnmore
    30 Espianade
    PA16 7RU Greenock
    Administrateur
    Carnmore
    30 Espianade
    PA16 7RU Greenock
    ScotlandBritishBishop1062850003
    MORAN, Peter Antony, The Right Reverend
    Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    10
    Ross-Shire
    Scotland
    Administrateur
    Cathedral Square
    IV10 8TB Fortrose
    10
    Ross-Shire
    Scotland
    ScotlandBritishBishop94932080002
    MURRAY, Ian, Right Reverend
    Bishops House
    Esplanade
    PA34 5AB Oban
    Argyll
    Administrateur
    Bishops House
    Esplanade
    PA34 5AB Oban
    Argyll
    ScotlandBritishBishop98429190001
    ROBSON, Stephen, Bishop
    34 West Main Street
    EH52 5RJ Broxburn
    Ss John Cantius & Nicholas Church
    West Lothian
    Scotland
    Administrateur
    34 West Main Street
    EH52 5RJ Broxburn
    Ss John Cantius & Nicholas Church
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritishRoman Catholic Bishop176905610001
    TARTAGLIA, Philip, The Right Reverend
    19 Park Circus
    Glasgow
    G3 6BE Lanarkshire
    Administrateur
    19 Park Circus
    Glasgow
    G3 6BE Lanarkshire
    ScotlandBritishBishop151340720001
    TAYLOR, Maurice, Right Reverend
    Candida Casa 8 Corsehill Road
    KA7 2ST Ayr
    Ayrshire
    Administrateur
    Candida Casa 8 Corsehill Road
    KA7 2ST Ayr
    Ayrshire
    BritishBishop419400001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Catholic Bishops Conference Of Scotland
    Aitken Street
    ML6 6LT Airdrie
    64
    Scotland
    06 avr. 2016
    Aitken Street
    ML6 6LT Airdrie
    64
    Scotland
    Non
    Forme juridiquePermanently Constitued Assembly
    Autorité légaleRoman Catholic Canon Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SCOTTISH CATHOLIC INTERNATIONAL AID FUND a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 janv. 2021
    Livré le 15 janv. 2021
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 janv. 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2020
    Livré le 17 déc. 2020
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 09 janv. 2008
    Livré le 18 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    19 park circus, glasgow GLA139595.
    Personnes ayant droit
    • The Scottish Ministers
    Transactions
    • 18 janv. 2008Enregistrement d'une charge (410)
    • 18 févr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0