PACIFIC SHELF 888 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PACIFIC SHELF 888 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC199010 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| Adresse du siège social | 4th Floor 115 George Street EH2 4JN Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 13 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 29 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 22 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Jeanette Leach en tant qu'administrateur le 09 déc. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Isaac Akintayo en tant que directeur le 09 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 22 pages | AA | ||
Nomination de Mr Isaac Akintayo en tant qu'administrateur le 12 juil. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Andy Muir en tant que directeur le 12 juil. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 22 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Rebecca Tamara Massey en tant qu'administrateur le 16 mars 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 22 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Andy Muir en tant qu'administrateur le 28 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Mark William Grinonneau en tant que directeur le 28 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Ms Lesley Alison Mcgregor en tant qu'administrateur le 14 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Wayne Michael Ashton en tant que directeur le 14 oct. 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 22 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Wayne Michael Ashton en tant qu'administrateur le 31 mars 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Christine Desiree Winstanley en tant que directeur le 31 mars 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Neil Geoffrey Ward en tant que directeur le 07 déc. 2020 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Mr Mark William Grinonneau en tant qu'administrateur le 07 déc. 2020 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 21 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 29 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARTLEY, Jeremy Peter | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | England | British | 118857570001 | |||||
| LEACH, Jeanette | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 330428190001 | |||||
| MASSEY, Rebecca Tamara | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | England | British | 307277630001 | |||||
| MCGREGOR, Lesley Alison | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | England | British | 287867170001 | |||||
| JOHNSTON, David Weir Cameron | Secrétaire | Stranadarrif Greenock Road PA4 9LB Inchinnan Renfrewshire | British | 39120630001 | ||||||
| MILLER, Janette Michele | Secrétaire | Chanters Farm Chanters Avenue, Atherton M46 9EF Manchester | British | 51677270003 | ||||||
| RAWLINSON, Deborah Jane | Secrétaire | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | 209519380001 | |||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||
| AKINTAYO, Isaac | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House England | England | British | 323190420001 | |||||
| ANDERSON, Patricia Ann | Administrateur | Sceptre Way PR5 6AW Bamber Bridge Sceptre House United Kingdom | England | British | 197968260001 | |||||
| ASHTON, Wayne Michael | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 256478460001 | |||||
| CARTER, James Francis | Administrateur | Pear Tree Cottage Pear Tree Lane PR7 6DU Euxton Lancashire | England | British | 10423690002 | |||||
| CLAXTON, Humphrey Kenneth Haslam | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | United Kingdom | British | 87740250001 | |||||
| COLLIER, Michael Edward | Administrateur | Chanters Farmhouse Chanters Avenue M46 9EF Atherton Manchester | England | British | 13163480002 | |||||
| DAY, Mark | Administrateur | 115 George Street EH2 4JN Edinburgh 4th Floor Scotland | England | British | 157242280001 | |||||
| FITZGERALD, Brian John Peter | Administrateur | The Gable South Avenue Thornliepark PA2 7SP Paisley Renfrewshire | British | 37064300002 | ||||||
| FRASER, George Gabriel | Administrateur | 7 Fairways Altonburn Road IV12 5NB Nairn Highland | Scotland | British | 50219540001 | |||||
| GRICE, Neil Keith | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | England | British | 182538290001 | |||||
| GRINONNEAU, Mark William | Administrateur | Suite 12b, Manchester One 53 Portland Street M1 3LD Manchester Community Health Partnerships England | United Kingdom | British | 323896400001 | |||||
| HARDY, Adrian Paul | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | England | British | 7158890001 | |||||
| HEMMING, Eric Rodney | Administrateur | Keepers Cottage Islay Road FY8 4AD Lytham St. Annes Lancashire | England | British | 84030950002 | |||||
| JOHNSTON, David Weir Cameron | Administrateur | Stranadarrif Greenock Road PA4 9LB Inchinnan Renfrewshire | British | 39120630001 | ||||||
| MEIKLE, Stewart Robert | Administrateur | 20 Belford Gardens EH4 3EW Edinburgh | Scotland | British | 70911700001 | |||||
| MUIR, Andy | Administrateur | Suite 12b, Manchester One 53 Portland Street M1 3LD Manchester Community Health Partnerships England | England | British | 289273870001 | |||||
| NICOLL, Peter William, Mr. | Administrateur | 32 Thorn Road Bearsden G61 4BS Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 287380001 | |||||
| ROWE, Peter | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | United Kingdom | British | 162029690001 | |||||
| SPENCE, Graham Michael | Administrateur | Sceptre Way PR5 6AW Bamber Bridge Sceptre House United Kingdom | United Kingdom | British | 155741260001 | |||||
| SUTHERLAND, David Fraser | Administrateur | Oldtown Of Leys Farm Culduthel IV2 6AE Inverness | Scotland | British | 1321720003 | |||||
| TURPIN, Richard | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | United Kingdom | British | 147202400001 | |||||
| WARD, Neil Geoffrey | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | United Kingdom | British | 64005130002 | |||||
| WARD, Neil Geoffrey | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House United Kingdom | United Kingdom | British | 64005130002 | |||||
| WINSTANLEY, Christine Desiree | Administrateur | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | England | British | 197967020001 | |||||
| JORDANS (SCOTLAND) LIMITED | Administrateur désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000000001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PACIFIC SHELF 888 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foundation For Life Limited | 06 avr. 2016 | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Sceptre House Lancashire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0