KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED

KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC200611
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    • (7012) /

    Où se situe KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    69 St Vincent Street
    Glasgow
    G2 5TF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HOMACK (NO. 62) LIMITED07 oct. 199907 oct. 1999

    Quels sont les derniers comptes de KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    4 pagesMG05s

    legacy

    3 pagesMG04s

    legacy

    3 pagesMG04s

    legacy

    3 pagesMG04s

    legacy

    3 pagesMG04s

    legacy

    3 pagesMG04s

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 mars 2008

    18 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    2 pages122

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    Comptes annuels établis au 31 mars 2007

    16 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    8 pages363s

    Comptes annuels établis au 31 mars 2006

    16 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 31 mars 2005

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CLARK, Graham Iain
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    Secrétaire
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    British94940840001
    CLARK, Graham Iain
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    Administrateur
    412 Castle Gait
    PA1 2HE Paisley
    ScotlandBritish94940840001
    GLEN, Maurice
    17 Juniper Avenue
    PA11 3NS Bridge Of Weir
    Administrateur
    17 Juniper Avenue
    PA11 3NS Bridge Of Weir
    ScotlandBritish1408430004
    CUSACK, Suzanne
    57 Tiree, St Leonards
    G74 2DR East Kilbride
    Secrétaire
    57 Tiree, St Leonards
    G74 2DR East Kilbride
    British76515980001
    GLEN, Susan Munro Inglis
    54 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    Strathclyde
    Secrétaire
    54 Dunellan Road
    Milngavie
    G62 7RE Glasgow
    Strathclyde
    British37382080001
    DOMICILE EXECUTORS TRUSTEES & NOMINEES LIMITED
    109 Douglas Street
    G2 4HB Glasgow
    Secrétaire
    109 Douglas Street
    G2 4HB Glasgow
    269420001
    IRVINE, Alasdair Iain
    13 Bent Road
    ML3 6QB Hamilton
    South Lanarkshire
    Administrateur
    13 Bent Road
    ML3 6QB Hamilton
    South Lanarkshire
    United KingdomBritish66640060002
    KEIR, Gordon John Millar
    42 Kilbarchan Road
    PA11 3EZ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Administrateur
    42 Kilbarchan Road
    PA11 3EZ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    United KingdomBritish80335540002
    MCLEW, Kenneth David Brownlie
    15 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    15 Hamilton Avenue
    Pollokshields
    G41 4JG Glasgow
    Lanarkshire
    British719600001
    MCNEILL, James Stuart
    13 Springkell Gardens
    Pollokshields
    G41 4BP Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    13 Springkell Gardens
    Pollokshields
    G41 4BP Glasgow
    Lanarkshire
    British719610001

    KILPATRICK PROPERTIES (CADZOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 18 nov. 2005
    Livré le 23 nov. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The golden lion filling station, montrose road, arbroath ang 3019.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Legal charge
    Créé le 28 juin 2005
    Livré le 08 juil. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over the freehold property known as 8 station road, ashington, northumberland (title number ND45518).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 juil. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Standard security
    Créé le 25 févr. 2005
    Livré le 01 mars 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    8-10 high street, ayr AYR27163.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 01 mars 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Legal charge
    Créé le 05 oct. 2004
    Livré le 18 oct. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Legal mortgage over 22 highgate, kendal cumbria CU153834.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 oct. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Standard security
    Créé le 23 avr. 2004
    Livré le 30 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    16 high street, alloa.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 05 janv. 2004
    Livré le 15 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    62/66 high street, leven.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 15 janv. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 22 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    50 high street, johnstone--title number REN884.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 13 janv. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04s)
    Standard security
    Créé le 13 mars 2003
    Livré le 27 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    103 main street, coatbridge.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 18 déc. 2002
    Livré le 24 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    52C high street, johnstone--title number REN18601.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 déc. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 19 janv. 2000
    Livré le 25 janv. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 févr. 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0