BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD

BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC201535
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction

    Où se situe BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Adresse du siège social
    3 Arthur Street
    Clarkston
    G76 8BQ Glasgow
    Lanarkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WESTPOINT (MEARNS) LIMITED24 déc. 199924 déc. 1999
    MACNEWCO FORTY LIMITED12 nov. 199912 nov. 1999

    Quels sont les derniers comptes de BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 janv. 2015

    État du capital au 30 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2015

    État du capital au 29 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 janv. 2015

    État du capital au 29 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen William Cullis le 31 janv. 2014

    4 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Ian Rigby le 30 sept. 2014

    3 pagesCH03

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 déc. 2011

    État du capital au 09 déc. 2011

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG03s

    legacy

    3 pagesMG02s

    legacy

    3 pagesMG02s

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 sept. 2008

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIGBY, Ian
    3 Arthur Street
    Clarkston
    G76 8BQ Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    3 Arthur Street
    Clarkston
    G76 8BQ Glasgow
    Lanarkshire
    British83129180002
    CULLIS, Stephen William
    3 Arthur Street
    Clarkston
    G76 8BQ Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Arthur Street
    Clarkston
    G76 8BQ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish361020003
    DICKSON, Graham Robert
    30a Victoria Park Gardens South
    G11 7BX Glasgow
    Administrateur
    30a Victoria Park Gardens South
    G11 7BX Glasgow
    ScotlandBritish62549370002
    CULLIS, Anne
    Beechwood Grange
    Thorntonhall
    Glasgow
    Secrétaire
    Beechwood Grange
    Thorntonhall
    Glasgow
    British979160002
    MACDONALDS
    St Stephen's House
    Bath Street
    G2 4JL Glasgow
    279
    Secrétaire désigné
    St Stephen's House
    Bath Street
    G2 4JL Glasgow
    279
    900016680001
    WHITE, Joyce Helen
    171 Queen Victoria Drive
    Scotstonhill
    G14 9BP Glasgow
    Administrateur
    171 Queen Victoria Drive
    Scotstonhill
    G14 9BP Glasgow
    ScotlandBritish17992770001

    BEECHWOOD DEVELOPMENT COMPANY (SCOTLAND) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 18 sept. 2003
    Livré le 30 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under a joint venture agreement
    Brèves mentions
    Subjects at glasgow road, edinburgh under title number MID48713.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 30 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Standard security
    Créé le 18 sept. 2003
    Livré le 25 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    160 glasgow road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 29 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 sept. 2003
    Livré le 10 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 10 sept. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 12 nov. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Deed of variation
    Créé le 08 mars 2002
    Livré le 27 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    Any sums due or which may become due in terms of the loan agreement
    Brèves mentions
    Subjects at berkley street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 27 mars 2002Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 févr. 2002
    Livré le 12 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    133 wallace street and 161, 171 and 173 west street, glasgow and 151,153 and 155 wallace street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 12 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 01 févr. 2002
    Livré le 05 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    133 wallace street and 161, 171 and 173 west street, glasgow and 151,153 & 155 wallace street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 21 janv. 2002
    Livré le 25 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 25 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 janv. 2002
    Livré le 29 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flats 1,2,3,4,5 & 6 fraser court, 4 queens gardens, dowanhill, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 29 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 janv. 2002
    Livré le 14 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Flats 1-6, fraser court, 4 queens gardens, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 07 janv. 2002
    Livré le 16 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due in connection with a minute of agreement dated 7 january 2002
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 16 janv. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Assignation
    Créé le 11 juin 2001
    Livré le 26 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £200,000
    Brèves mentions
    The first £200,000 due to the company in terms of the minute of agreement between the company, cala finance limited and stephen william cullis relating to the development of 90 kelvinhaugh street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 26 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 11 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,181,250
    Brèves mentions
    Subjects at kelvinhaugh street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 11 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 05 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    34 berkeley street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 29 août 2000
    Livré le 05 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground at kelvinhaugh street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 05 sept. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 03 août 2000
    Livré le 09 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 09 août 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 oct. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 26 mai 2000
    Livré le 08 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    34 berkeley street, glasgow.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 08 juin 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 mai 2000
    Livré le 17 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 17 mai 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 oct. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 10 mars 2000
    Livré le 17 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    1.45 hectares at west acres, newton mearns, renfrewshire.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 10 mars 2000
    Livré le 17 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of piece of ground at westacres, newton mearns, renfrewshire.
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 17 mars 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 févr. 2000
    Livré le 23 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cala Management Limited
    Transactions
    • 23 févr. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 16 mars 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 oct. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 23 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 nov. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 20 janv. 2000
    Livré le 25 janv. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 janv. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 17 mars 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 août 2000Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 01 oct. 2001Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 14 janv. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 05 févr. 2002Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 25 sept. 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 11 nov. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 24 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0