MIND TOOLS LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MIND TOOLS LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC202102 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MIND TOOLS LTD ?
| Adresse du siège social | 21 Young Street EH2 4HU Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MIND TOOLS LTD ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2024 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2023 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MIND TOOLS LTD ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MIND TOOLS LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC2021020011, créée le 13 juin 2025 | 30 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC2021020010, créée le 13 juin 2025 | 32 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC2021020008, créée le 07 mai 2025 | 19 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge SC2021020009, créée le 07 mai 2025 | 51 pages | MR01 | ||||||||||
Notification de Mind Tools Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mai 2025 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Andrew Synder en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 02 mai 2025 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 02 mai 2025
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC2021020006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge SC2021020007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Tracy Balachandran en tant que directeur le 28 févr. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Rachat d'actions propres. | 4 pages | SH03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 déc. 2024 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 28 oct. 2024
| 6 pages | SH06 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Tracy Balachandran le 30 oct. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Shabnam Shahani le 30 oct. 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , Level 1, 50 Frederick Street, Edinburgh, EH2 1EX, Scotland à 21 Young Street Edinburgh EH2 4HU le 30 oct. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 25 sept. 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 25 juin 2024
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Statuts | 46 pages | MA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 07 mai 2024
| 6 pages | SH06 | ||||||||||
Rachat d'actions propres. | 4 pages | SH03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emma Jane Tregenza en tant que directeur le 09 mai 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emma Jane Tregenza en tant que secrétaire le 09 mai 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de MIND TOOLS LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BREHM, Matthew | Administrateur | Wisconsin Avenue Suite 850 20814 Bethesda 7550 Maryland United States | United States | American | 301121950001 | |||||||||
| SHAHANI, Shabnam | Administrateur | Young Street EH2 4HU Edinburgh 21 Scotland | England | British | 314406100001 | |||||||||
| SHARMA, Pankaj | Administrateur | 7th Avenue New York 888 United States | United States | American | 313524650001 | |||||||||
| TRAINOR, Larisa Avner | Administrateur | Wisconsin Avenue Suite 850 20814 Bethesda 7550 Maryland United States | United States | American | 296161760001 | |||||||||
| BOLGER, David Arthur William | Secrétaire | 6 Bramdean Place EH10 6JS Edinburgh | British | 67233520003 | ||||||||||
| FERGUSON, Owen | Secrétaire | 22 North West Thistle Street Lane EH2 1BY Edinburgh Stewart House United Kingdom | 161797480001 | |||||||||||
| FERRIER, Gordon Alexander | Secrétaire | 2 Corstorphine Park Gardens EH12 7HH Edinburgh Midlothian | British | 83529080001 | ||||||||||
| MCCALLUM, Catherine Isobel Edith | Secrétaire | 160 Dundee Street Edinburgh EH11 1DQ Lothian | British | 94822050001 | ||||||||||
| ROBINSON, Kathryn | Secrétaire | 22 North West Thistle Street Lane EH2 1BY Edinburgh Stewart House | 198885510001 | |||||||||||
| TREGENZA, Emma Jane | Secrétaire | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | 209791890001 | |||||||||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom |
| 133157900001 | ||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secrétaire désigné | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||
| BALACHANDRAN, Tracy | Administrateur | Young Street EH2 4HU Edinburgh 21 Scotland | United Kingdom | British | 322273460001 | |||||||||
| BELL, Emma Jane | Administrateur | 22 North West Thistle Street Lane EH2 1BY Edinburgh Stewart House United Kingdom | Scotland | British | 170314340001 | |||||||||
| BEVAN, Richard Lloyd | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | England | British | 129901670001 | |||||||||
| BURDEN, Jonathan Edward | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | United Kingdom | British | 242691330001 | |||||||||
| CASEBOW, Peter Brian | Administrateur | 6 Lawhead Place EH26 9JU Penicuik Midlothian | United Kingdom | British | 78881020001 | |||||||||
| CORNISH, Zoe | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | England | British | 256575810001 | |||||||||
| COX, Simon Guy | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | England | British | 185671020001 | |||||||||
| CRADDOCK, Oliver | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | United Kingdom | British | 256575620001 | |||||||||
| CURRY, Paul | Administrateur | 22 North West Thistle Street Lane EH2 1BY Edinburgh Stewart House United Kingdom | United Kingdom | British | 170840470001 | |||||||||
| DOWDING, Melanie | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | England | British | 265882200001 | |||||||||
| FARROW, Ewan Francis | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | United Kingdom | British | 288054510001 | |||||||||
| FERGUSON, Owen | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | United Kingdom | British | 152794040001 | |||||||||
| FERRIER, Gordon Alexander | Administrateur | 2 Corstorphine Park Gardens EH12 7HH Edinburgh Midlothian | British | 83529080001 | ||||||||||
| FOJT, Melissa Clare | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | United Kingdom | British | 251053090001 | |||||||||
| FORD, Margaret Anne, Baroness | Administrateur | 6 Bramdean Place EH10 6JS Edinburgh Midlothian | British | 70511990003 | ||||||||||
| HOWELL, Keith Martin | Administrateur | White Moss EH46 7BS West Linton Peeblesshire | Scotland | British | 1499960007 | |||||||||
| JOCELYN, Patrick | Administrateur | Frederick Street EH2 1EX Edinburgh Level 1, 50 Scotland | England | British | 134180730001 | |||||||||
| KEENAN, Christopher Russell | Administrateur | 22 North West Thistle Street Lane EH2 1BY Edinburgh Stewart House | England | British | 198885420001 | |||||||||
| LLOYD, Antony John | Administrateur | Old School Fields TN22 5DH Uckfield Bramleys Sussex Uk | England | British | 131058250001 | |||||||||
| MALIN, Johanne | Administrateur | 15 Riverside Road Craigiehall EH30 9TP South Queensferry West Lothian | British | 114201230001 | ||||||||||
| MCCALLUM, Catherine Isobel Edith | Administrateur | 20 Blinkbonny Crescent EH4 3NB Edinburgh | Great Britain | British | 94822050001 | |||||||||
| MCPHERSON, Catherine Linda | Administrateur | 30 Dublin Street EH3 6NN Edinburgh Midlothian | British | 67603610001 | ||||||||||
| OVERTON, Laura | Administrateur | Wagon Lane BD16 1WA Bingley Howard House West Yorkshire England | England | British | 232893940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MIND TOOLS LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mind Tools Holdings Ltd | 02 mai 2025 | 21 - 23 Wellington Street LS1 4DL Leeds Floor 5 Northspring England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Andrew Synder | 31 août 2023 | 17th Floor NY 10019 New York, 888 7th Avenue, United States | Oui | ||||||||||
Nationalité: American Pays de résidence: United States | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Emerald Group Holdings Limited | 16 oct. 2016 | Dowley Gap Business Park, Dowley Gap Lane BD16 1WA Bingley Howard House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0