BLOXX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLOXX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC202264
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLOXX LIMITED ?

    • fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques (26200) / Industries manufacturières

    Où se situe BLOXX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Bothwell Street
    G2 6NL Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BLOXX LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PACKET DYNAMICS LIMITED24 déc. 199924 déc. 1999
    NEWCO (602) LIMITED10 déc. 199910 déc. 1999

    Quels sont les derniers comptes de BLOXX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BLOXX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    9 pages4.26(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de The Alba Centre the Alba Campus Livingston EH54 7EG à 25 Bothwell Street Glasgow G2 6NL le 24 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 sept. 2016

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Gerald Deck en tant que directeur le 27 sept. 2016

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2015

    État du capital au 16 déc. 2015

    • Capital: GBP 1,804,920
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    1 pagesAD02

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2016 au 31 déc. 2015

    3 pagesAA01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2015

    9 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    État du capital après une attribution d'actions au 29 oct. 2015

    • Capital: GBP 1,804,920.00
    5 pagesSH01

    Nomination de Mr Christopher Douglas Saxe en tant qu'administrateur le 30 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de 5th Floor 125 Princes Street Edinburgh EH2 4AD à The Alba Centre the Alba Campus Livingston EH54 7EG le 02 nov. 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Dee Eamon Ward en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graham Kennedy Twaddle en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Charles Sweeney en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Peter Mcgoff en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Mark Robert Hunter Gibson en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Hugh Evans en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Colin Scott Mcgill en tant que directeur le 30 oct. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Gerald Deck en tant qu'administrateur le 30 oct. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Brodies Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 oct. 2015

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Mbm Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 30 oct. 2015

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de BLOXX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Scotland
    Secrétaire
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Scotland
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC210264
    79799970001
    SAXE, Christopher Douglas
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building X1a
    Surrey
    England
    Administrateur
    Aviator Park
    Station Road
    KT15 2PG Addlestone
    Building X1a
    Surrey
    England
    United KingdomAmerican197853230001
    EVANS, William Hugh
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    Secrétaire
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    British60816590002
    EVANS, William Hugh
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    Secrétaire
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    British60816590002
    LOWE, Robert Gardiner
    16
    Rose Terrace
    PH1 5HA Perth
    Flat 1,
    Perth & Kinross
    United Kingdom
    Secrétaire
    16
    Rose Terrace
    PH1 5HA Perth
    Flat 1,
    Perth & Kinross
    United Kingdom
    British147243610001
    MACLAREN, Peter James
    2 Glencairn Crescent
    EH12 5BS Edinburgh
    Secrétaire
    2 Glencairn Crescent
    EH12 5BS Edinburgh
    British51112640001
    STEVENS, Geoffrey Alan
    9 Murieston Park
    EH54 9DT Livingston
    West Lothian
    Secrétaire
    9 Murieston Park
    EH54 9DT Livingston
    West Lothian
    British122753750001
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrementSC156630
    133157900001
    MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Secrétaire
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    42680350001
    BECK, Ute
    24 Panmure Place
    EH3 9JJ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    24 Panmure Place
    EH3 9JJ Edinburgh
    Midlothian
    German9491550001
    CAMPBELL, David James
    Jeanfield Farm
    Carnwath
    ML11 8LJ Lanarkshire
    Administrateur
    Jeanfield Farm
    Carnwath
    ML11 8LJ Lanarkshire
    ScotlandBritish1417270003
    DECK, Gerald
    Parkring
    Garching
    29
    85748
    Germany
    Administrateur
    Parkring
    Garching
    29
    85748
    Germany
    GermanyGerman202287280001
    DOYLE, Eamonn
    The Carthouse
    Dykedale Farm
    FK15 0JU Dunblane
    Administrateur
    The Carthouse
    Dykedale Farm
    FK15 0JU Dunblane
    ScotlandScottish90396910002
    EVANS, William Hugh
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    Administrateur
    2 Buckstane Park
    Comiston
    EH10 6PA Edinburgh
    ScotlandBritish60816590002
    GIBSON, Mark Robert Hunter
    EH54 7EG Livingston
    The Alba Centre
    United Kingdom
    Administrateur
    EH54 7EG Livingston
    The Alba Centre
    United Kingdom
    United KingdomBritish121494650001
    IRVINE, Paul Robert
    13 Teviot Drive
    EH54 9JW Livingston
    Administrateur
    13 Teviot Drive
    EH54 9JW Livingston
    Gb-SctBritish98412550002
    LAING, Keith
    5 Wellview Lane
    EH54 9HU Murieston
    Administrateur
    5 Wellview Lane
    EH54 9HU Murieston
    ScotlandBritish205555550001
    LOWE, Robert Gardiner
    16
    Rose Terrace
    PH1 5HA Perth
    Flat 1,
    Perth & Kinross
    Scotland
    Administrateur
    16
    Rose Terrace
    PH1 5HA Perth
    Flat 1,
    Perth & Kinross
    Scotland
    United KingdomBritish147243610001
    MACLAREN, Peter James
    2 Glencairn Crescent
    EH12 5BS Edinburgh
    Administrateur
    2 Glencairn Crescent
    EH12 5BS Edinburgh
    ScotlandBritish51112640001
    MATHER, James Stuart
    Sutherland Avenue
    Pollockshields
    G41 4JJ Glasgow
    13
    United Kingdom
    Administrateur
    Sutherland Avenue
    Pollockshields
    G41 4JJ Glasgow
    13
    United Kingdom
    ScotlandBritish49750800001
    MCGILL, Colin Scott
    Wester Coates Avenue
    EH12 5LS Edinburgh
    10
    United Kingdom
    Administrateur
    Wester Coates Avenue
    EH12 5LS Edinburgh
    10
    United Kingdom
    United KingdomBritish663080001
    MCGOFF, Andrew Peter
    Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    11
    United Kingdom
    Administrateur
    Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    11
    United Kingdom
    ScotlandBritish134370820001
    MCNAIR, Ian Spence
    13 Middlepenny Place
    PA14 6XD Langbank
    Renfrewshire
    Administrateur
    13 Middlepenny Place
    PA14 6XD Langbank
    Renfrewshire
    ScotlandBritish116922000001
    PATTULLO, Robert Michael
    39 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    Administrateur
    39 Heriot Row
    EH3 6ES Edinburgh
    ScotlandBritish54596190001
    SMITH, Robert Mark
    Swift Brae
    EH54 6GY Livingston
    9
    West Lothian
    Administrateur
    Swift Brae
    EH54 6GY Livingston
    9
    West Lothian
    United KingdomBritish136200200001
    SWEENEY, Charles
    Williamwood Park West
    G44 3TE Glasgow
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    Williamwood Park West
    G44 3TE Glasgow
    9
    United Kingdom
    ScotlandBritish58158990002
    TWADDLE, Graham Kennedy
    Shore Road
    G84 0HJ Kilcreggan
    Windward House
    United Kingdom
    Administrateur
    Shore Road
    G84 0HJ Kilcreggan
    Windward House
    United Kingdom
    United KingdomBritish71248570001
    WARD, Dee Eamon
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    Administrateur
    Floor
    125 Princes Street
    EH2 4AD Edinburgh
    5th
    ScotlandBritish22035830009
    MBM BOARD NOMINEES LIMITED
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    Administrateur désigné
    39 Castle Street
    EH2 3BH Edinburgh
    900016000001

    BLOXX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Bond & floating charge
    Créé le 21 oct. 2004
    Livré le 04 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 nov. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 nov. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 30 oct. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 juin 2004
    Livré le 30 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wl Ventures Limited
    Transactions
    • 30 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 juin 2004
    Livré le 30 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • West Lothian Venture Fund Limited
    Transactions
    • 30 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 16 mai 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 10 juin 2004
    Livré le 30 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise
    Transactions
    • 30 juin 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 01 déc. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 08 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 06 janv. 2003
    Livré le 13 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 13 janv. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 28 oct. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 07 févr. 2002
    Livré le 11 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Scottish Enterprise
    Transactions
    • 11 févr. 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 mai 2003Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 17 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui

    BLOXX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 sept. 2016Commencement of winding up
    09 juil. 2019Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0