CHANGE HOMES LTD.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHANGE HOMES LTD.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC203911
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHANGE HOMES LTD. ?

    • (7487) /

    Où se situe CHANGE HOMES LTD. ?

    Adresse du siège social
    Third Floor West Edinburgh Quay 2
    139 Fountainbridge
    EH3 9QG Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHANGE HOMES LTD. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UK BUILDING SUPPLIES LIMITED07 mars 200007 mars 2000
    M M & S (2615) LIMITED14 févr. 200014 févr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CHANGE HOMES LTD. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour CHANGE HOMES LTD. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de réunion finale des créanciers

    3 pages4.17(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de Atholl Exchange 6 Canning Street Edinburgh EH3 8EG le 08 avr. 2013

    2 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal avis de liquidation

    1 pagesCO4.2(Scot)

    Avis de liquidation

    1 pages4.2(Scot)

    Changement d'adresse du siège social de 7-11 Melville Street Edinburgh EH3 7PE le 14 nov. 2011

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur provisoire

    1 pages4.9(Scot)

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Kevin Mccabe en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    5 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    6 pages363s

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2007

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2006

    6 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    2 pages419b(Scot)

    legacy

    2 pages419b(Scot)

    legacy

    2 pages419b(Scot)

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages410(Scot)

    legacy

    6 pages363s

    Qui sont les dirigeants de CHANGE HOMES LTD. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FAIRGRIEVE, Scott
    33 The Village
    Archerfield Estate, Dirleton
    EH39 5HT North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    33 The Village
    Archerfield Estate, Dirleton
    EH39 5HT North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritishProperty Developer80505660003
    FAIRGRIEVE, Denise Helen
    57 Laburnum Avenue
    Port Seton
    EH32 0UD Lothian
    Secrétaire
    57 Laburnum Avenue
    Port Seton
    EH32 0UD Lothian
    British92142860001
    FAIRGRIEVE, Scott
    57 Laburnham Avenue
    EH32 0UD Port Seton
    East Lothian
    Secrétaire
    57 Laburnham Avenue
    EH32 0UD Port Seton
    East Lothian
    British80505660002
    MCCABE, Kevin Timbrell
    Archerfield Estate
    By Dirleton
    EH39 5HT North Berwick
    10 The Village
    Secrétaire
    Archerfield Estate
    By Dirleton
    EH39 5HT North Berwick
    10 The Village
    Scottish100799370004
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secrétaire désigné
    St. Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    151
    900003400001
    FAIRGRIEVE, Denise Helen
    57 Laburnum Avenue
    Port Seton
    EH32 0UD Lothian
    Administrateur
    57 Laburnum Avenue
    Port Seton
    EH32 0UD Lothian
    BritishAdministrator92142860001
    FAIRGRIEVE, Scott
    57 Laburnham Avenue
    EH32 0UD Port Seton
    East Lothian
    Administrateur
    57 Laburnham Avenue
    EH32 0UD Port Seton
    East Lothian
    BritishDirector80505660002
    SCOTT, Kenneth David Bertram
    45 Daiches Braes
    EH15 2RD Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    45 Daiches Braes
    EH15 2RD Edinburgh
    Midlothian
    BritishDirector68832010001
    CHANGE GROUP LIMITED
    17 Rothesay Place
    EH3 7SQ Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    17 Rothesay Place
    EH3 7SQ Edinburgh
    Midlothian
    98872790001
    VINDEX LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003390001
    VINDEX SERVICES LIMITED
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    Administrateur désigné
    151 St Vincent Street
    G2 5NJ Glasgow
    900003380001

    CHANGE HOMES LTD. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 01 mai 2007
    Livré le 10 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    That plot of ground known as ormiston farm, kirknewton MID61163 MID57180.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 10 mai 2007Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 09 mai 2005
    Livré le 12 mai 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    That area of ground extending to 806 square metres at stanley avenue, bilston adjacent to numbers 8 to 18 stanley avenue, bilston, midlothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 mai 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 18 avr. 2005
    Livré le 27 avr. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Drygrange mains farm steading, melrose ROX747 under exception of drygrange mains farm cottage number one.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 avr. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 08 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the sme standard security conditions dated 27 january 2004
    Brèves mentions
    Dalhousie chesters, by bonnyrigg, midlothian.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 26 nov. 2004
    Livré le 08 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the sme standard security conditions dated 27 january 2004
    Brèves mentions
    Garage site at the glebe, standingstane road, dalmeny.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 déc. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 2004
    Livré le 14 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Dalhousie chesters by bonnyrigg--title number MID49147.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 14 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 01 avr. 2004
    Livré le 08 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Plots 1 & 2, alder road, port seton.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 08 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 mars 2004
    Livré le 30 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The garden lodge, plot number 60, willowbrae gardens housing development, edinburgh known as willowbrae house, 86 willowbrae road, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 22 mars 2004
    Livré le 30 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The garden lodge, willowbrae gardens housing development, edinburgh (title number MID58088).
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 30 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Floating charge
    Créé le 22 déc. 2003
    Livré le 24 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 24 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 25 sept. 2003
    Livré le 02 oct. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects comprising the stables and other out buildings and ground attached to dalhousie chesters, by bonnyrigg.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 23 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mars 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 08 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 14 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 04 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Bond & floating charge
    Créé le 11 juil. 2003
    Livré le 18 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 juil. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mars 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 08 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 14 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 04 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    Standard security
    Créé le 04 mars 2003
    Livré le 24 mars 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due in terms of the personal bond dated 17 february 2003
    Brèves mentions
    Subjects at 74 high street, portobello, edinburgh.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 mars 2003Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 22 févr. 2003
    Livré le 27 févr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The whole assets of the company.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 févr. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 30 mars 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 08 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 14 avr. 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)
    • 04 juin 2007Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (419b)

    CHANGE HOMES LTD. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 oct. 2011Petition date
    01 nov. 2011Conclusion of winding up
    12 oct. 2011Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Pamela Coyne
    Atholl Exchange 6 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    provisional liquidator
    Atholl Exchange 6 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info
    2
    DateType
    20 mars 2014Dissolved on
    01 nov. 2011Petition date
    11 déc. 2013Conclusion of winding up
    01 nov. 2011Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Pamela Coyne
    Atholl Exchange 6 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    practitioner
    Atholl Exchange 6 Canning Street
    EH3 8EG Edinburgh
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0