CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société SC203999
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    • Location et exploitation de biens immobiliers des sociétés de logement (68201) / Activités immobilières

    Où se situe CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    7 Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    pagesCERTIPS

    Divers

    Fca's form b & form z converting company into a mutual society.
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    The company has been converted into a community benefit society 10/03/2016
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2016 sans liste des membres

    10 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    30 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Councillor William Goldie le 18 nov. 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2015 sans liste des membres

    10 pagesAR01

    Divers

    Section 519
    2 pagesMISC

    Comptes annuels établis au 31 mars 2014

    29 pagesAA

    Cessation de la nomination de Craig Jon Moule en tant que secrétaire le 26 août 2014

    1 pagesTM02

    Nomination de Ms Sophie Atkinson en tant que secrétaire le 26 août 2014

    2 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2014 sans liste des membres

    11 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Christina Anderson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2013

    28 pagesAA

    Nomination de Mr Adam Gordon Alexander Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2013 sans liste des membres

    9 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    30 pagesAA

    Nomination de Councillor William Goldie en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Councillor Allan George Graham en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Christina Anderson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Hugh Gough en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Daniel Carrigan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 févr. 2012 sans liste des membres

    10 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    27 pagesAA

    Cessation de la nomination de William Homer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ATKINSON, Sophie
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Secrétaire
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    190472660001
    CLARK, Alexander Hendry Murdoch
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishNone56184990005
    GOLDIE, William, Councillor
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandScottishSenior Biomedical Scientist122816950001
    GRAHAM, Allan George
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishInformation Trainer/Presenter And Councillor171814150001
    HOMER, Alice
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired106696650002
    JONES, Frances Jane
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishHousing Officer133551860001
    KNOX, Williamina
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishP/T Clerkess135250840001
    MACKENZIE, George Murray
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCounsellor75484200001
    PAYNE, John
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    ScotlandBritishNone85918780001
    SMITH, Adam Gordon Alexander
    Tarbolton Road
    Cumbernauld
    G67 2AF Glasgow
    5a
    Scotland
    Administrateur
    Tarbolton Road
    Cumbernauld
    G67 2AF Glasgow
    5a
    Scotland
    ScotlandBritishCivil Servant177770160001
    WEST, Alan Findlay
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinancial Consultant83185920001
    HANVEY, John Howie
    33 St Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    Secrétaire
    33 St Marys Drive
    PH2 7BY Perth
    Perthshire
    British368510001
    HOPE, Colin Douglas
    6 Thornyhall
    Dalkeith
    EH22 2ND Midlothian
    Secrétaire
    6 Thornyhall
    Dalkeith
    EH22 2ND Midlothian
    BritishChief Executive88762600001
    INGLIS, William
    38a Clouden Road
    Kildrum
    G67 2EW Cumbernauld
    Lanarkshire
    Secrétaire
    38a Clouden Road
    Kildrum
    G67 2EW Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired72806780002
    MAXWELL, William Lowrie Maxwell
    23 Alder Road
    Abronhill
    G67 3AD Cumbernauld
    Lanarkshire
    Secrétaire
    23 Alder Road
    Abronhill
    G67 3AD Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105150520001
    MOULE, Craig Jon
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Secrétaire
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    British146507680001
    LEDINGHAM CHALMERS
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Secrétaire désigné
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    900003330001
    ANDERSON, Christina
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    Administrateur
    Freeland Drive
    Priesthill
    G53 6PG Glasgow
    7
    United KingdomBritishRetired165829820001
    BARRIE, Michael
    70 Beechwood Road
    Cumbernauld
    G67 2NP Lanarkshire
    Administrateur
    70 Beechwood Road
    Cumbernauld
    G67 2NP Lanarkshire
    BritishRetired85525040001
    BOWIE, Rose Lafferty Richardson
    68 Greenrigg Road
    Cumbernauld
    G67 2PR Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    68 Greenrigg Road
    Cumbernauld
    G67 2PR Glasgow
    Lanarkshire
    BritishHousewife71104020001
    BROTHERTON, Colin
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    Administrateur
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    BritishBank Manager92611530001
    BROTHERTON, Colin
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    Administrateur
    51 Avalon Gardens
    EH49 7QE Linlithgow
    BritishBank Manager92611530001
    CARRIGAN, Daniel, Councillor
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCouncillor122150310001
    CLARK, Alexander Hendry Murdoch
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired56184990005
    DUNCAN, Brian David
    12d Campbell House
    Berryhill Road
    G67 1LX Cumbernauld
    North Lanark
    Administrateur
    12d Campbell House
    Berryhill Road
    G67 1LX Cumbernauld
    North Lanark
    BritishRetired76879350001
    DUNPHY, Elizabeth
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    Administrateur
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    United KingdomBritishDirector94022840001
    DUNPHY, Elizabeth
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    Administrateur
    46g Braeface Road
    G67 1HQ Cumbernauld
    United KingdomBritishRetired94022840001
    EDGAR, Frances
    96 Torbrex Road
    G67 2JS Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    96 Torbrex Road
    G67 2JS Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishHomemaker119688920001
    GODFREY, Robert Paton Miller
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105357990001
    GODFREY, Robert Paton Miller
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    63d Douglas House
    G67 1HB Cumbernauld
    Lanarkshire
    BritishRetired105357990001
    GOLDIE, William, Councillor
    40 Halidon Avenue
    G67 4FB Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    40 Halidon Avenue
    G67 4FB Cumbernauld
    Lanarkshire
    ScotlandScottishDirector122816950001
    GOUGH, Hugh
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired116338470001
    GOUGH, Hugh
    91 Torbrex Road
    G67 2JX Cumbernauld
    Lanarkshire
    Administrateur
    91 Torbrex Road
    G67 2JX Cumbernauld
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired116338470001
    HARDY, Mary Motherwell
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    Administrateur
    7 Freeland Drive
    G53 6PG Glasgow
    Sanctuary House
    Lanarkshire
    ScotlandBritishRetired119687270001
    HENDRIE, Ann
    4a Wallace House
    Berryhill Road, Cumbernauld
    G67 1LU Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    4a Wallace House
    Berryhill Road, Cumbernauld
    G67 1LU Glasgow
    Lanarkshire
    BritishRetired68314870001

    CUMBERNAULD HOUSING PARTNERSHIP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 31 mars 2004
    Livré le 20 avr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    5B,5C,5D,6A,6B,6C,6D,7A,7C,7D,8C,9A elliot house, kildrum; 1,11,13,15,17,19,21,23,25,27,3,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,5,51,53,55,57,59,61,7,9,liddell road, ravenswood; 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34 beechwood court, carbrain; 1A,10B,11A,11C,11D,2A,2B,2C,2D,3A,3B,3C,4A,4B,4C,4D,5A elliot house, kildrum,all cumbernauld.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 20 avr. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 14 déc. 2000
    Livré le 29 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    £20,000,000
    Brèves mentions
    Carbrain estate, ravenswood estate, seafar estate, muirhead estate, kildrum estate and village estate, all cumbernauld.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 29 déc. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Standard security
    Créé le 14 déc. 2000
    Livré le 29 déc. 2000
    En cours
    Montant garanti
    £20,000,000
    Brèves mentions
    Superiority of carbrain estate, ravenswood estate, seafar estate, muirhead estate, kildrum estate and village estate, all cumbernauld.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 29 déc. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    Bond & floating charge
    Créé le 20 nov. 2000
    Livré le 24 nov. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society
    Transactions
    • 24 nov. 2000Enregistrement d'une charge (410)
    • 10 nov. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (MG05s)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0