GOLF COAST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGOLF COAST PLC
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société SC205283
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GOLF COAST PLC ?

    • Installations de fitness (93130) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe GOLF COAST PLC ?

    Adresse du siège social
    22a Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    Midlothian
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GOLF COAST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MAP ASSET HOLDINGS PLC07 mars 201407 mars 2014
    MAP ASSET HOLDINGS LIMITED07 mars 201407 mars 2014
    WHITEKIRK LEISURE LIMITED21 mars 200021 mars 2000

    Quels sont les derniers comptes de GOLF COAST PLC ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour GOLF COAST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2015

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 avr. 2016

    État du capital au 14 avr. 2016

    • Capital: GBP 800,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 oct. 2014

    20 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed map asset holdings PLC\certificate issued on 08/05/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name08 mai 2015

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 avr. 2015

    État du capital au 08 avr. 2015

    • Capital: GBP 800,000
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 22a Rutland Square Edinburgh Midlothian EH2 2BB

    1 pagesAD04

    Inscription de la charge SC2052830005, créée le 22 janv. 2015

    40 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Donald George Paterson en tant que directeur le 11 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan John Bate en tant qu'administrateur le 22 oct. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 oct. 2013

    7 pagesAA

    Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 21 mars 2014

    17 pagesRP04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    1 pagesAD02

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2014

    État du capital au 06 mai 2014

    • Capital: GBP 800,000
    SH01
    Annotations
    DateAnnotation
    13 juin 2014A second filed AR01 was registered on 13/06/2014.

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Appointment of director and resignation of secretary 11/03/2014
    RES13

    Cessation de la nomination de Richard Spanner en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Mr Donald George Paterson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Bilan

    1 pagesBS

    Rapport d'audit

    2 pagesAUDR

    Déclaration de l'auditeur

    1 pagesAUDS

    Qui sont les dirigeants de GOLF COAST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PURPLE VENTURE SECRETARIES LIMITED
    George Square
    Castle Brae
    KY11 8QF Dunfermline
    1
    United Kingdom
    Secrétaire
    George Square
    Castle Brae
    KY11 8QF Dunfermline
    1
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement05215935
    185757810001
    BATE, Alan John
    3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    Real Estate Associates
    United Kingdom
    Administrateur
    3 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7DD London
    Real Estate Associates
    United Kingdom
    EnglandBritish92396420001
    SPANNER, Richard Timothy
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Administrateur
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    ScotlandBritish68850790003
    WEATHERBY, Scott
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Administrateur
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    ScotlandBritish147052620001
    SPANNER, Richard Timothy
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Secrétaire
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    British174550300001
    TUER, Robin
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Secrétaire
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    British77909070003
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Secrétaire désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    PATERSON, Donald George
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Administrateur
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    ScotlandBritish158034750003
    TUER, Carl
    Swansfield House
    NE66 1EJ Alnwick
    Northumberland
    Administrateur
    Swansfield House
    NE66 1EJ Alnwick
    Northumberland
    United KingdomBritish69054060004
    TUER, George Robert
    West Lodge
    Seacliffe
    EH42 1SZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    West Lodge
    Seacliffe
    EH42 1SZ North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritish18609730003
    TUER, Joesephine Mary
    West Lodge
    Seacliffe
    EH42 1SX North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    West Lodge
    Seacliffe
    EH42 1SX North Berwick
    East Lothian
    United KingdomBritish70243890003
    TUER, Robin
    Rock South Farm
    NE66 5LG Alnwick
    Gull-Ha
    Northumberland
    United Kingdom
    Administrateur
    Rock South Farm
    NE66 5LG Alnwick
    Gull-Ha
    Northumberland
    United Kingdom
    United KingdomBritish77909070005
    WHELLANS, Ronald
    6 Dirleton Avenue
    EH39 4AY North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    6 Dirleton Avenue
    EH39 4AY North Berwick
    East Lothian
    British77909110003
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Administrateur désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GOLF COAST PLC ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Richard Timothy Spanner
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    06 avr. 2016
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Scott Weatherby
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    06 avr. 2016
    Rutland Square
    EH2 2BB Edinburgh
    22a
    Midlothian
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: Scotland
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    GOLF COAST PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 janv. 2015
    Livré le 05 févr. 2015
    En cours
    Brève description
    Leasehold interest in the land registered at the land registry under title number eln 7647.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Real Estate Associates Limited
    Transactions
    • 05 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Standard security
    Créé le 16 déc. 2003
    Livré le 22 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of ground forming part of the tenant's interest in the lease of subjects registered in the land register of scotland under title number ELN3700.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Bond & floating charge
    Créé le 17 nov. 2003
    Livré le 25 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2003Enregistrement d'une charge (410)
    • 20 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge flottante (MG03s)
    Standard security
    Créé le 13 déc. 2001
    Livré le 20 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Whitekirk golf and country club, whitekirk, by dunbar, east kilbride.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 20 déc. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 13 juin 2001
    Livré le 28 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 juin 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 15 juin 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0