INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social |
| Numéro de société | SC208244 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| Adresse du siège social | Collins House Rutland Square EH1 2AA Edinburgh |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 juil. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 15 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 01 juil. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 13 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Miss Kathryn Mullaney en tant qu'administrateur le 28 févr. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023 | 14 pages | AA | ||
Nomination de Mr Graeme Houston Livingstone en tant qu'administrateur le 10 janv. 2025 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jennifer Mary Mcpartlin en tant que directeur le 06 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Lee Macleod en tant qu'administrateur le 02 août 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mrs Ashley Bisland en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Derek Cooke en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Miss Emma Woolsey en tant que secrétaire le 02 févr. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Ashley Mcclymont Rennie en tant que directeur le 12 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Alex Dillon en tant que directeur le 02 avr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Andrew Nugent en tant qu'administrateur le 01 juin 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Jennifer Mary Mcpartlin en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 14 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Nichola Kane en tant que directeur le 19 mars 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Peter Beagley en tant que secrétaire le 02 févr. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Peter Beagley en tant que directeur le 02 févr. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Notification de Sgs Finco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 janv. 2021 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de la nomination de Benjamin Aaron Doyle en tant que directeur le 28 juin 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de Intu Debenture Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 janv. 2021 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Zunainah Waheed-Saleemi en tant qu'administrateur le 05 janv. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Jackie Connolly en tant que directeur le 05 janv. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOLSEY, Emma | Secrétaire | Braehead Shopping Centre Kings Inch Rd G51 4BN Renfrew PO BOX Scotland | 325138530001 | |||||||
| BISLAND, Ashley | Administrateur | King's Inch Rd G51 4BN Renfrew C/O Braehead Shopping Centre Scotland | Scotland | British | 218181200001 | |||||
| COOKE, Derek | Administrateur | Braehead Shopping Centre G51 4BS Glasgow Primark Scotland | Scotland | Irish | 325139110001 | |||||
| LIVINGSTONE, Graeme Houston | Administrateur | Braehead Centre Kings Inch Road G51 4BP Glasgow Boots, Unit 68 Scotland | Scotland | British | 331673290001 | |||||
| MACLEOD, Lee | Administrateur | C/O Braehead Shopping Centre King's Inch Road G51 4BS Glasgow Mcdonald's United Kingdom | Scotland | Scottish | 325839770001 | |||||
| MULLANEY, Kathryn | Administrateur | Braehead Shopping Centre Kings Inch Road G51 4BP Glasgow M&S Braehead United Kingdom | United Kingdom | British | 258288770001 | |||||
| NUGENT, Andrew | Administrateur | Unit 173 Braehead Shopping Centre Kings Inch Road G52 4BS Glasgow Next Retail United Kingdom | United Kingdom | British | 323303200001 | |||||
| THOMPSON, Roisin Sarah Catherine | Administrateur | Kings Inch Road G51 4BS Glasgow Lush, Unit 140b, Braehead Shopping Centre Scotland | Scotland | Scottish | 298066830001 | |||||
| WAHEED-SALEEMI, Zunainah | Administrateur | Kings Inch Road Braehead G51 4BN Glasgow Unit 61&62 Scotland | Scotland | British,Pakistani | 311280020001 | |||||
| WOOLSEY, Emma | Administrateur | Kings Inch Rd G51 4bn Renfrew Braehead Shopping Centre Scotland | Scotland | British | 285318380001 | |||||
| BALDRY, Robert | Secrétaire | Grianan Wallace Road PA18 6AG Wemyss Bay Renfrewshire | British | 80553850001 | ||||||
| BEAGLEY, Peter | Secrétaire | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House | 241845010001 | |||||||
| BEAGLEY, Peter | Secrétaire | 7 Tarbert Drive EH54 9GZ Murieston Valley West Lothian | British | 99608280002 | ||||||
| TURNBULL, Gary | Secrétaire | Kings Inch Road G51 4BN Glasgow Intu Braehead Scotland | 189461560001 | |||||||
| SECRETAR SECURITIES LIMITED | Secrétaire | 249 West George Street G2 4RB Glasgow | 77605900001 | |||||||
| ADAMSON, Craig Howden | Administrateur | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House Scotland | Scotland | British | 159612680001 | |||||
| AGNEW, Joyce | Administrateur | Braehead Shopping Centre Kings Inch Road G51 4BP Glasgow Thomas Cook Scotland | Scotland | British | 199595550001 | |||||
| ALEXANDER, Gordon | Administrateur | Silvertonhill Avenue ML3 7PF Hamilton 182 Lanarkshire | United Kingdom | British | 131199160001 | |||||
| ANDERSON, Paul James | Administrateur | Inverawe St Margarets Drive FK15 0DP Dunblane Perthshire | British | 58693300001 | ||||||
| BALDRY, Robert | Administrateur | Grianan Wallace Road PA18 6AG Wemyss Bay Renfrewshire | Scotland | British | 80553850001 | |||||
| BATES, David Gordon | Administrateur | Avalon Gardens Linlithgow Bridge EH49 7PL Linlithgow 105 West Lothian | Scotland | British | 135074480001 | |||||
| BEAGLEY, Peter | Administrateur | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House | Scotland | British | 99608280002 | |||||
| BEAGLEY, Peter | Administrateur | 7 Tarbert Drive EH54 9GZ Murieston Valley West Lothian | Scotland | British | 99608280002 | |||||
| BERTRAM, Patricia Anne | Administrateur | Kings Inch Road Renfrew Unit 12 United Kingdom | United Kingdom | British | 212496060002 | |||||
| BLACKBURN, Sarah | Administrateur | The Carthouse Dykedale FK15 0JU Dunblane Perthshire | British | 84025350002 | ||||||
| BLOODWORTH, Sarah | Administrateur | 8 Ivybridge Close TW1 1EA Twickenham Middlesex | British | 83730960001 | ||||||
| BROWN, Mark | Administrateur | 16 Murchison Road Crosslee PA6 7JU Johnstone Renfrewshire | British | 66259720002 | ||||||
| CAMERON, Josephine | Administrateur | 61 Bathgo Avenue PA1 3EA Ralston Renfrewshire | British | 116174540001 | ||||||
| CAMPBELL, Malcolm | Administrateur | Millstream Court PA1 1RR Paisley 88 Renfrewshire | British | 137730180001 | ||||||
| CODMAN, Jonathan | Administrateur | Ardenconnel Cottage Church Road, Rhu G84 8RW Helensburgh Dunbartonshire | British | 77201120001 | ||||||
| CONNOLLY, Jackie | Administrateur | Intu Braehead Kings Inch Road G51 4BP Glasgow H&M Scotland | Scotland | British | 189461610001 | |||||
| COUGHLIN, Angela | Administrateur | Rutland Square EH1 2AA Edinburgh Collins House Scotland | United Kingdom | British | 170717080001 | |||||
| CRAIG, Pamela | Administrateur | Kings Inch Road G51 4BN Glasgow Thorntons United Kingdom | United Kingdom | British | 110694310001 | |||||
| CROALL, Gerardine Veronica | Administrateur | 4 Baldoran Drive Milton Of Campsie G66 8FZ Glasgow | British | 77201130001 | ||||||
| CROALL, Gerardine Veronica | Administrateur | 4 Baldoran Drive Milton Of Campsie G66 8FZ Glasgow | British | 77201130001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sgs Finco Limited | 22 janv. 2021 | Churchill Place 10th Floor E14 5HU London 5 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Intu Debenture Plc | 04 juin 2016 | Broadway SW1H 0BT London 40 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0