INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED

INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC208244
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Collins House
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED19 juin 200019 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation15 juil. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au01 juil. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Miss Kathryn Mullaney en tant qu'administrateur le 28 févr. 2025

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023

    14 pagesAA

    Nomination de Mr Graeme Houston Livingstone en tant qu'administrateur le 10 janv. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jennifer Mary Mcpartlin en tant que directeur le 06 août 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Lee Macleod en tant qu'administrateur le 02 août 2024

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Ashley Bisland en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Derek Cooke en tant qu'administrateur le 01 avr. 2024

    2 pagesAP01

    Nomination de Miss Emma Woolsey en tant que secrétaire le 02 févr. 2024

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ashley Mcclymont Rennie en tant que directeur le 12 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alex Dillon en tant que directeur le 02 avr. 2024

    1 pagesTM01

    Nomination de Andrew Nugent en tant qu'administrateur le 01 juin 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Jennifer Mary Mcpartlin en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Nichola Kane en tant que directeur le 19 mars 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Beagley en tant que secrétaire le 02 févr. 2024

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Peter Beagley en tant que directeur le 02 févr. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Sgs Finco Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 janv. 2021

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Benjamin Aaron Doyle en tant que directeur le 28 juin 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de Intu Debenture Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 janv. 2021

    1 pagesPSC07

    Nomination de Zunainah Waheed-Saleemi en tant qu'administrateur le 05 janv. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jackie Connolly en tant que directeur le 05 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WOOLSEY, Emma
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    PO BOX
    Scotland
    Secrétaire
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    PO BOX
    Scotland
    325138530001
    BISLAND, Ashley
    King's Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    C/O Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Administrateur
    King's Inch Rd
    G51 4BN Renfrew
    C/O Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandBritish218181200001
    COOKE, Derek
    Braehead Shopping Centre
    G51 4BS Glasgow
    Primark
    Scotland
    Administrateur
    Braehead Shopping Centre
    G51 4BS Glasgow
    Primark
    Scotland
    ScotlandIrish325139110001
    LIVINGSTONE, Graeme Houston
    Braehead Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Boots, Unit 68
    Scotland
    Administrateur
    Braehead Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Boots, Unit 68
    Scotland
    ScotlandBritish331673290001
    MACLEOD, Lee
    C/O Braehead Shopping Centre
    King's Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Mcdonald's
    United Kingdom
    Administrateur
    C/O Braehead Shopping Centre
    King's Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Mcdonald's
    United Kingdom
    ScotlandScottish325839770001
    MULLANEY, Kathryn
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    M&S Braehead
    United Kingdom
    Administrateur
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    M&S Braehead
    United Kingdom
    United KingdomBritish258288770001
    NUGENT, Andrew
    Unit 173 Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G52 4BS Glasgow
    Next Retail
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 173 Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G52 4BS Glasgow
    Next Retail
    United Kingdom
    United KingdomBritish323303200001
    THOMPSON, Roisin Sarah Catherine
    Kings Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Lush, Unit 140b, Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Administrateur
    Kings Inch Road
    G51 4BS Glasgow
    Lush, Unit 140b, Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandScottish298066830001
    WAHEED-SALEEMI, Zunainah
    Kings Inch Road
    Braehead
    G51 4BN Glasgow
    Unit 61&62
    Scotland
    Administrateur
    Kings Inch Road
    Braehead
    G51 4BN Glasgow
    Unit 61&62
    Scotland
    ScotlandBritish,Pakistani311280020001
    WOOLSEY, Emma
    Kings Inch Rd
    G51 4bn
    Renfrew
    Braehead Shopping Centre
    Scotland
    Administrateur
    Kings Inch Rd
    G51 4bn
    Renfrew
    Braehead Shopping Centre
    Scotland
    ScotlandBritish285318380001
    BALDRY, Robert
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Secrétaire
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    British80553850001
    BEAGLEY, Peter
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Secrétaire
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    241845010001
    BEAGLEY, Peter
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    Secrétaire
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    British99608280002
    TURNBULL, Gary
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Intu Braehead
    Scotland
    Secrétaire
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Intu Braehead
    Scotland
    189461560001
    SECRETAR SECURITIES LIMITED
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    Secrétaire
    249 West George Street
    G2 4RB Glasgow
    77605900001
    ADAMSON, Craig Howden
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    ScotlandBritish159612680001
    AGNEW, Joyce
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Thomas Cook
    Scotland
    Administrateur
    Braehead Shopping Centre
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    Thomas Cook
    Scotland
    ScotlandBritish199595550001
    ALEXANDER, Gordon
    Silvertonhill Avenue
    ML3 7PF Hamilton
    182
    Lanarkshire
    Administrateur
    Silvertonhill Avenue
    ML3 7PF Hamilton
    182
    Lanarkshire
    United KingdomBritish131199160001
    ANDERSON, Paul James
    Inverawe St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    Inverawe St Margarets Drive
    FK15 0DP Dunblane
    Perthshire
    British58693300001
    BALDRY, Robert
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    Administrateur
    Grianan
    Wallace Road
    PA18 6AG Wemyss Bay
    Renfrewshire
    ScotlandBritish80553850001
    BATES, David Gordon
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    105
    West Lothian
    Administrateur
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    105
    West Lothian
    ScotlandBritish135074480001
    BEAGLEY, Peter
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Administrateur
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    ScotlandBritish99608280002
    BEAGLEY, Peter
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    Administrateur
    7 Tarbert Drive
    EH54 9GZ Murieston Valley
    West Lothian
    ScotlandBritish99608280002
    BERTRAM, Patricia Anne
    Kings Inch Road
    Renfrew
    Unit 12
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Inch Road
    Renfrew
    Unit 12
    United Kingdom
    United KingdomBritish212496060002
    BLACKBURN, Sarah
    The Carthouse
    Dykedale
    FK15 0JU Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    The Carthouse
    Dykedale
    FK15 0JU Dunblane
    Perthshire
    British84025350002
    BLOODWORTH, Sarah
    8 Ivybridge Close
    TW1 1EA Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    8 Ivybridge Close
    TW1 1EA Twickenham
    Middlesex
    British83730960001
    BROWN, Mark
    16 Murchison Road
    Crosslee
    PA6 7JU Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    16 Murchison Road
    Crosslee
    PA6 7JU Johnstone
    Renfrewshire
    British66259720002
    CAMERON, Josephine
    61 Bathgo Avenue
    PA1 3EA Ralston
    Renfrewshire
    Administrateur
    61 Bathgo Avenue
    PA1 3EA Ralston
    Renfrewshire
    British116174540001
    CAMPBELL, Malcolm
    Millstream Court
    PA1 1RR Paisley
    88
    Renfrewshire
    Administrateur
    Millstream Court
    PA1 1RR Paisley
    88
    Renfrewshire
    British137730180001
    CODMAN, Jonathan
    Ardenconnel Cottage
    Church Road, Rhu
    G84 8RW Helensburgh
    Dunbartonshire
    Administrateur
    Ardenconnel Cottage
    Church Road, Rhu
    G84 8RW Helensburgh
    Dunbartonshire
    British77201120001
    CONNOLLY, Jackie
    Intu Braehead
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    H&M
    Scotland
    Administrateur
    Intu Braehead
    Kings Inch Road
    G51 4BP Glasgow
    H&M
    Scotland
    ScotlandBritish189461610001
    COUGHLIN, Angela
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    Administrateur
    Rutland Square
    EH1 2AA Edinburgh
    Collins House
    Scotland
    United KingdomBritish170717080001
    CRAIG, Pamela
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Thorntons
    United Kingdom
    Administrateur
    Kings Inch Road
    G51 4BN Glasgow
    Thorntons
    United Kingdom
    United KingdomBritish110694310001
    CROALL, Gerardine Veronica
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    Administrateur
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    British77201130001
    CROALL, Gerardine Veronica
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    Administrateur
    4 Baldoran Drive
    Milton Of Campsie
    G66 8FZ Glasgow
    British77201130001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTU BRAEHEAD MERCHANTS ASSOCIATION LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Churchill Place
    10th Floor
    E14 5HU London
    5
    England
    22 janv. 2021
    Churchill Place
    10th Floor
    E14 5HU London
    5
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement08355746
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Intu Debenture Plc
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    England
    04 juin 2016
    Broadway
    SW1H 0BT London
    40
    England
    Oui
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementUk Registrar Of Companies
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement5890611
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0