KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED

KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC210217
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    • Établissements de soins infirmiers en résidence (87100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    50 Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OPTIONWEALTH LIMITED21 août 200021 août 2000

    Quels sont les derniers comptes de KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Jonathan David Farkas en tant que directeur le 07 juin 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Stephen Welch en tant qu'administrateur le 07 juin 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 21 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 sept. 2015

    État du capital au 18 sept. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan David Farkas le 20 juil. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 20 juil. 2015

    1 pagesCH04

    Nomination de Jonathan David Farkas en tant qu'administrateur le 27 janv. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mathieu Strieff en tant que directeur le 27 janv. 2015

    1 pagesTM01

    legacy

    28 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    legacy

    1 pagesAGREEMENT1

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 sept. 2014

    État du capital au 17 sept. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sanne Group Secretaries (Uk) Limited le 31 mars 2014

    1 pagesCH04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mathieu Strieff le 31 mars 2014

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Secrétaire
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8334728
    175738460001
    WELCH, Richard Stephen
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Administrateur
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    United StatesAmericanCompany Director249076190001
    GALLACHER, Charles
    79a Pettycur Road
    Kinghorn
    KY3 9RP Burntisland
    Fife
    Secrétaire
    79a Pettycur Road
    Kinghorn
    KY3 9RP Burntisland
    Fife
    BritishConsultant62875600001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    British52338530002
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CORMACK, Derek George
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Pillars
    Grantley Avenue, Wonersh
    GU5 0QN Guildford
    Surrey
    EnglandIrishAccountant67400530015
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Bulilding 2nd Floor
    England
    Administrateur
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Bulilding 2nd Floor
    England
    LuxembourgAmericanManaging Director193539990003
    GALLACHER, Charles
    79a Pettycur Road
    Kinghorn
    KY3 9RP Burntisland
    Fife
    Administrateur
    79a Pettycur Road
    Kinghorn
    KY3 9RP Burntisland
    Fife
    BritishConsultant62875600001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishProperty Developer154122490001
    HILL, Peter Martin
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    NICOL, David
    Aberlyn House
    Charlestown
    KY11 3DP Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    Aberlyn House
    Charlestown
    KY11 3DP Dunfermline
    Fife
    BritishCompany Director62965840001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    STRIEFF, Mathieu
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United Kingdom
    UsaAmericanAttorney181635310001
    WHITE, Ian James
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Gannel Hill View
    Fishcross
    FK10 3GN Alloa
    C/O Marchglen Care Home
    Clackmannanshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant133383410003
    JORDANS (SCOTLAND) LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Administrateur désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000000001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 avr. 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleThe Companies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04258255
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    KINGDOM CARE (HILLVIEW COURT) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Standard security
    Créé le 03 août 2010
    Livré le 16 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Area of land at hillview court nursing home sauchie alloa clk 7370.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 12 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Bond & floating charge
    Créé le 28 juil. 2010
    Livré le 11 août 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 août 2010Enregistrement d'une charge (MG01s)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 30 nov. 2007
    Livré le 06 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Hillview court nursing home, craigbank, sauchie, alloa CLK7370.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 03 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Debenture including legal mortgage, fixed charges and floating charge over all assets and assignments - see form 410 schedule for full details.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge
    Créé le 16 nov. 2007
    Livré le 03 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 déc. 2007Enregistrement d'une charge (410)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Standard security
    Créé le 08 nov. 2005
    Livré le 14 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as hillview court nursing home, craigbank, sauchie CLK7370.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 28 oct. 2005
    Livré le 07 nov. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 nov. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 06 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juil. 2004
    Livré le 20 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming hillview court nursing home, craigbank, sauchie (title number CLK7370).
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 20 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 09 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Standard security
    Créé le 09 juil. 2004
    Livré le 17 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    The subjects known as and forming hillview court nursing home, craigbank, sauchie--title number CLK7370.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 04 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02s)
    Floating charge
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 16 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 16 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 23 juil. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 06 déc. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Bond & floating charge
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 08 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 08 juil. 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 21 juil. 2004Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • 09 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Standard security
    Créé le 19 janv. 2001
    Livré le 07 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Ground extending 1.03 hectares west of main street, sauchie, alloa.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 févr. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 29 déc. 2000
    Livré le 18 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 18 janv. 2001Enregistrement d'une charge (410)
    • 08 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0