UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC210964 |
Juridiction | Écosse |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED ?
Adresse du siège social | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew William Alan Grant le 30 sept. 2020 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Matthew William Alan Grant le 24 mai 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 19 mars 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 25 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Paul Anthony Smith en tant que directeur le 30 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Sandeep Uppal en tant qu'administrateur le 30 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Bernhard Bruggaier en tant que directeur le 30 sept. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Matthew William Alan Grant en tant qu'administrateur le 30 sept. 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 24 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Paul Anthony Smith en tant qu'administrateur le 19 sept. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Cameron en tant que directeur le 19 sept. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 19 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 sept. 2018 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 18 juil. 2018
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURNESS PAULL LLP | Secrétaire | Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh 50 Scotland |
| 194531900001 | ||||||||||||||
GRANT, Matthew William Alan | Administrateur | Ferry Road NR1 1SW Norwich Ferryside Norfolk United Kingdom | England | British | Company Director | 140298430012 | ||||||||||||
UPPAL, Sandeep | Administrateur | 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza (6th Floor) | England | British | Company Director | 199272750001 | ||||||||||||
BROWN, Dianne | Secrétaire | 44 Murieston Valley Road EH54 9HB Livingston West Lothian | British | 72163450001 | ||||||||||||||
HAWTHORN, Irene | Secrétaire | St. Johns Road Corstorphine EH12 7SB Edinburgh 121 | British | Legal Secretary | 115886400001 | |||||||||||||
PRYKE, Margaret | Secrétaire | 24/1 Sinclair Place EH11 1AN Edinburgh | British | 103753920001 | ||||||||||||||
BRIAN REID LTD. | Secrétaire désigné | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||||||||||
MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire | 107 George Street EH2 3ES Edinburgh | 42680350002 | |||||||||||||||
STRONACHS SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Albyn Place AB10 1FW Aberdeen 34 |
| 129592570001 | ||||||||||||||
BROWN, Dianne | Administrateur | 9 Skivo Wynd Murieston EH54 9GY Livingston West Lothian | United Kingdom | British | Director | 72163450002 | ||||||||||||
BROWN, Douglas John | Administrateur | 9 Skivo Wynd Murieston EH54 9GY Livingston West Lothian | United Kingdom | British | Engineering Surveyor | 72163410002 | ||||||||||||
BRUGGAIER, Bernhard, Dr | Administrateur | Ferry Road NR1 1SW Norwich Ferryside England | Germany | German | Company Director | 116750390001 | ||||||||||||
CAMERON, Stuart | Administrateur | 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza (6th Floor) Scotland | Scotland | British | Company Director | 218498790001 | ||||||||||||
CASTELL, Andrew Sean | Administrateur | Exchange Tower 19 Canning Street EH3 8EH Edinburgh C/O Par Equity Llp Uk | United Kingdom | British | Company Director | 142569410001 | ||||||||||||
HOEY, James | Administrateur | 30 Callander Road Chapelhall ML6 8HA Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | Telecoms Specialist | 152085260002 | ||||||||||||
MILLER, William | Administrateur | Spires Business Units Mugiemoss Road AB21 9NY Aberdeen Utec House United Kingdom | Scotland | British | Director | 106374550001 | ||||||||||||
O'CARROLL, Martin Christopher | Administrateur | Spires Business Units Mugiemoss Road AB21 9NY Aberdeen Utec House United Kingdom | Western Australia | Irish | Director | 110434220003 | ||||||||||||
RYAN, Brendan Seamus | Administrateur | Spires Business Units Mugiemoss Road AB21 9NY Aberdeen Utec House United Kingdom | United States Of America | American | Chief Operating Officer | 175184490001 | ||||||||||||
SMITH, Paul Anthony | Administrateur | Ferry Road NR1 1SW Norwich Ferryside Norfolk United Kingdom | Scotland | British | Company Director | 251045350001 | ||||||||||||
WILLIAMSON, Steven Bruce | Administrateur | Spires Business Units Mugiemoss Road AB21 9NY Aberdeen Utec House United Kingdom | Usa | American | Chief Financial Officer | 181924530001 | ||||||||||||
WILSON, John Andrew | Administrateur | 38 Carden Place AB10 1UP Aberdeen Lime Rock Partners | United Kingdom | British | Finance | 171496570001 | ||||||||||||
STEPHEN MABBOTT LTD. | Administrateur désigné | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utec International Limited | 06 avr. 2016 | 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza (6th Floor) Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Utec International Limited | 06 avr. 2016 | 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen Union Plaza (6th Floor) Scotland | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
UTEC STAR NET GEOMATICS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Créé le 20 déc. 2011 Livré le 23 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 11 août 2010 Livré le 25 août 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge | Créé le 02 juin 2009 Livré le 09 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 07 mai 2003 Livré le 23 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Bond & floating charge | Créé le 21 mai 2002 Livré le 28 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due | |
Brèves mentions The whole assets of the company. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0