SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | SC211524 |
Juridiction | Écosse |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | Carnbroe House Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Scotland |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 sept. 2025 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 10 oct. 2025 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 26 sept. 2024 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Comptes annuels établis au 31 mars 2024 | 30 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge SC2115240002 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2023 | 30 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2022 | 30 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Nomination de Mr Sydney Fudge en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Scott Mcfarlane en tant qu'administrateur le 06 mai 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Modification des détails de A.L.H. 86 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 mai 2020 | 2 pages | PSC05 | ||
Cessation de la nomination de David Laurence Weston en tant que secrétaire le 06 mai 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de David Laurence Weston en tant que directeur le 06 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes annuels établis au 31 mars 2021 | 28 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Sydney Robert Fudge en tant que directeur le 24 août 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Natalie Milne en tant qu'administrateur le 30 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Alan Murray en tant qu'administrateur le 30 juin 2021 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kevan Sturrock en tant que directeur le 29 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Graeme Robert Carling en tant que directeur le 29 juin 2021 | 1 pages | TM01 | ||
Inscription de la charge SC2115240002, créée le 03 juin 2021 | 14 pages | MR01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2020 au 31 mars 2021 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Carnbroe House 2 Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE Scotland à Carnbroe House Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE le 28 août 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 10 James Street Righead Industrial Estate Bellshill Lanarkshire ML4 3LU à Carnbroe House 2 Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE le 24 juil. 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 24 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUDGE, Sydney | Administrateur | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House Scotland | Scotland | British | Director | 299858540001 | ||||
MCFARLANE, Scott | Administrateur | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 295609950001 | ||||
MILNE, Natalie | Administrateur | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House Scotland | Scotland | British | Director | 284790880001 | ||||
MURRAY, Alan | Administrateur | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House Scotland | Scotland | British | Director | 284790470001 | ||||
KEOHANE, Lynda Jill | Secrétaire | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | 176017970001 | |||||||
KEOHANE, Lynda Jill | Secrétaire | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | 154467720001 | |||||||
REYNOLDS, David William | Secrétaire | High Street Bulkington SN10 1SJ Devizes Farthings Wiltshire United Kingdom | British | Financial Director | 136871710001 | |||||
SMITH, William Tom James | Secrétaire | Barnfield Farm Erlestoke SN10 5UE Devizes Wiltshire | British | Company Director | 9170340002 | |||||
STIRLING, Andrew | Secrétaire | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | 172536030001 | |||||||
WESTON, David Laurence | Secrétaire | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House Scotland | 222284010001 | |||||||
MENZIES DOUGAL WS | Secrétaire | 12 Bruntsfield Crescent EH10 4HA Edinburgh Midlothian | 412160001 | |||||||
BANKS, Michael | Administrateur | 54 Society Road EH30 9RX South Queensferry West Lothian | Scotland | British | Company Director | 41266160001 | ||||
BLACK, David Edward | Administrateur | 12 North Avenue G72 8AT Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | Director | 127795390001 | ||||
BROOKS, James | Administrateur | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Retire | 652100004 | ||||
CARLING, Graeme Robert | Administrateur | Harrison Road DD2 3SN Dundee Affinity House Scotland | Scotland | British | Director | 135443280002 | ||||
CLARKE, John Henry Alfred | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | Director | 9170350004 | ||||
ELLERBY, John Russell | Administrateur | 1 Badenheath Place Westfield G68 9HX Cumbernauld | Scotland | British | Assistant Chief Executive | 157562150002 | ||||
FUDGE, Sydney Robert | Administrateur | Harrison Road DD2 3SN Dundee Affinity House Scotland | Scotland | British | Director | 10630480001 | ||||
GUNDA, Mark | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | Director | 172536170001 | ||||
HASSELL, Katrina May | Administrateur | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Accountant | 182829720001 | ||||
KEOHANE, Lynda Jill | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Spain | British | Consultant | 157316890001 | ||||
LONGSTAFF, Alison Louise | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | United Kingdom | British | Accountant | 152555950001 | ||||
MCLAREN, Alan Cunningham | Administrateur | 12 Bruntsfield Crescent EH10 4HA Edinburgh Midlothian | British | Solicitor | 72140240002 | |||||
O'ROURKE, Patrick, Mr. | Administrateur | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Councillor | 207634120001 | ||||
PAUL, Ronald | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Council Officer | 84410001 | ||||
REYNOLDS, David William | Administrateur | High Street Bulkington SN10 1SJ Devizes Farthings Wiltshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 136871710001 | ||||
REYNOLDS, John | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Senior Operations Manager | 157584810001 | ||||
ROBERTSON, Douglas John | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Director | 81330470001 | ||||
SAUNDERS, Aaron | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire | Scotland | British | Director Of Business Compliance And Risk | 200110200001 | ||||
SMITH, William Tom James | Administrateur | Barnfield Farm Erlestoke SN10 5UE Devizes Wiltshire | British | Company Director | 9170340002 | |||||
SPOWART, Andrew | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Councillor | 172591780001 | ||||
STURROCK, Kevan | Administrateur | Harrison Road DD2 3SN Dundee Affinity House Scotland | Scotland | British | Director | 266464860001 | ||||
SULLIVAN, Peter | Administrateur | James Street Righead Industrial Estate ML4 3LU Bellshill 10 Lanarkshire Scotland | Scotland | British | Councillor | 156685840001 | ||||
TUCKER, Jane | Administrateur | 2 Georgian View Kingsway BA2 2LZ Bath Avon | British | Financial Director | 101625990001 | |||||
WESTON, David Laurence | Administrateur | Finch Way Strathclyde Business Park ML4 3PE Bellshill Carnbroe House Scotland | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 95558820001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North Lanarkshire Council | 06 avr. 2016 | Windmillhill Street ML1 1AB Motherwell Civic Centre Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
A.L.H. 86 Limited | 06 avr. 2016 | Northolt Road HA2 0EX Harrow Lawrence Johns 202 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0