SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED

SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC211524
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    • Installation de plomberie, de chauffage et de climatisation (43220) / Construction

    Où se situe SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Carnbroe House Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au26 sept. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation10 oct. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au26 sept. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Satisfaction de la charge SC2115240002 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2022

    30 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Sydney Fudge en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Scott Mcfarlane en tant qu'administrateur le 06 mai 2022

    2 pagesAP01

    Modification des détails de A.L.H. 86 Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 14 mai 2020

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de David Laurence Weston en tant que secrétaire le 06 mai 2022

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de David Laurence Weston en tant que directeur le 06 mai 2022

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2021

    28 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Sydney Robert Fudge en tant que directeur le 24 août 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Natalie Milne en tant qu'administrateur le 30 juin 2021

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Alan Murray en tant qu'administrateur le 30 juin 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Kevan Sturrock en tant que directeur le 29 juin 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graeme Robert Carling en tant que directeur le 29 juin 2021

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge SC2115240002, créée le 03 juin 2021

    14 pagesMR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2020 au 31 mars 2021

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 26 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Carnbroe House 2 Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE Scotland à Carnbroe House Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE le 28 août 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 10 James Street Righead Industrial Estate Bellshill Lanarkshire ML4 3LU à Carnbroe House 2 Finch Way Strathclyde Business Park Bellshill ML4 3PE le 24 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FUDGE, Sydney
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    Administrateur
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector299858540001
    MCFARLANE, Scott
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    United Kingdom
    Administrateur
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director295609950001
    MILNE, Natalie
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    Administrateur
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector284790880001
    MURRAY, Alan
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    Administrateur
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector284790470001
    KEOHANE, Lynda Jill
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    176017970001
    KEOHANE, Lynda Jill
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    154467720001
    REYNOLDS, David William
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    BritishFinancial Director136871710001
    SMITH, William Tom James
    Barnfield Farm
    Erlestoke
    SN10 5UE Devizes
    Wiltshire
    Secrétaire
    Barnfield Farm
    Erlestoke
    SN10 5UE Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director9170340002
    STIRLING, Andrew
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Secrétaire
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    172536030001
    WESTON, David Laurence
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    Secrétaire
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    222284010001
    MENZIES DOUGAL WS
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    412160001
    BANKS, Michael
    54 Society Road
    EH30 9RX South Queensferry
    West Lothian
    Administrateur
    54 Society Road
    EH30 9RX South Queensferry
    West Lothian
    ScotlandBritishCompany Director41266160001
    BLACK, David Edward
    12 North Avenue
    G72 8AT Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    12 North Avenue
    G72 8AT Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector127795390001
    BROOKS, James
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishRetire652100004
    CARLING, Graeme Robert
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    Administrateur
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector135443280002
    CLARKE, John Henry Alfred
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritishDirector9170350004
    ELLERBY, John Russell
    1 Badenheath Place
    Westfield
    G68 9HX Cumbernauld
    Administrateur
    1 Badenheath Place
    Westfield
    G68 9HX Cumbernauld
    ScotlandBritishAssistant Chief Executive157562150002
    FUDGE, Sydney Robert
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    Administrateur
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector10630480001
    GUNDA, Mark
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritishDirector172536170001
    HASSELL, Katrina May
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishAccountant182829720001
    KEOHANE, Lynda Jill
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    SpainBritishConsultant157316890001
    LONGSTAFF, Alison Louise
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    United KingdomBritishAccountant152555950001
    MCLAREN, Alan Cunningham
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    12 Bruntsfield Crescent
    EH10 4HA Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor72140240002
    O'ROURKE, Patrick, Mr.
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishCouncillor207634120001
    PAUL, Ronald
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishCouncil Officer84410001
    REYNOLDS, David William
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    Administrateur
    High Street
    Bulkington
    SN10 1SJ Devizes
    Farthings
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector136871710001
    REYNOLDS, John
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishSenior Operations Manager157584810001
    ROBERTSON, Douglas John
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishDirector81330470001
    SAUNDERS, Aaron
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector Of Business Compliance And Risk200110200001
    SMITH, William Tom James
    Barnfield Farm
    Erlestoke
    SN10 5UE Devizes
    Wiltshire
    Administrateur
    Barnfield Farm
    Erlestoke
    SN10 5UE Devizes
    Wiltshire
    BritishCompany Director9170340002
    SPOWART, Andrew
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishCouncillor172591780001
    STURROCK, Kevan
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    Administrateur
    Harrison Road
    DD2 3SN Dundee
    Affinity House
    Scotland
    ScotlandBritishDirector266464860001
    SULLIVAN, Peter
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    James Street
    Righead Industrial Estate
    ML4 3LU Bellshill
    10
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandBritishCouncillor156685840001
    TUCKER, Jane
    2 Georgian View
    Kingsway
    BA2 2LZ Bath
    Avon
    Administrateur
    2 Georgian View
    Kingsway
    BA2 2LZ Bath
    Avon
    BritishFinancial Director101625990001
    WESTON, David Laurence
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    Administrateur
    Finch Way
    Strathclyde Business Park
    ML4 3PE Bellshill
    Carnbroe House
    Scotland
    United KingdomBritishChartered Accountant95558820001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SALTIRE FACILITIES MANAGEMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    North Lanarkshire Council
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Scotland
    06 avr. 2016
    Windmillhill Street
    ML1 1AB Motherwell
    Civic Centre
    Scotland
    Oui
    Forme juridiqueLocal Authority
    Autorité légaleScottish Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    A.L.H. 86 Limited
    Northolt Road
    HA2 0EX Harrow
    Lawrence Johns 202
    England
    06 avr. 2016
    Northolt Road
    HA2 0EX Harrow
    Lawrence Johns 202
    England
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement02036774
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0