TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | SC212499 |
| Juridiction | Écosse |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 50 Lothian Road Festival Square EH3 9WJ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 16 nov. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 02 nov. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
replacement-filing-of-director-appointment-with-name | 3 pages | RP01AP01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2024 | 10 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Nomination de Claire Nicol Cattani en tant qu'administrateur le 22 août 2024 | 3 pages | AP01 | ||||||
| ||||||||
Cessation de la nomination de Casey Joseph Giovanetto en tant que directeur le 01 août 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2023 | 12 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2022 | 13 pages | AA | ||||||
Nomination de Casey Joseph Giovanetto en tant qu'administrateur le 31 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Gordon Hope en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Cessation de la nomination de David Alexander Lympany en tant que directeur le 31 mai 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Mr Daniel Julius Bernard Simonelli en tant qu'administrateur le 31 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mr Sharmilla Rani Tymchen en tant qu'administrateur le 31 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mr Steven Keith Luft en tant qu'administrateur le 31 mai 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2021 | 24 pages | AA | ||||||
Cessation de la nomination de Terry Joseph Bennett en tant que directeur le 15 déc. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Terry Joseph Bennett le 16 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Alexander Lympany le 16 nov. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 nov. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Cessation de Transcanada Pipelines Limtied en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC07 | ||||||
Notification de Tc Energy Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 2 pages | PSC02 | ||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2020 | 23 pages | AA | ||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 New Way Rutherglen Glasgow G73 1DH Scotland à 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ le 23 juil. 2021 | 1 pages | AD01 | ||||||
Qui sont les dirigeants de TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATTANI, Claire Nicol | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland Scotland | Canada | Canadian | 326534880001 | |||||
| LUFT, Steven Keith | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland Scotland | Canada | Canadian | 310295060001 | |||||
| SIMONELLI, Daniel Julius Bernard | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland Scotland | Canada | Canadian | 310295040001 | |||||
| TYMCHEN, Sharmilla Rani | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland Scotland | Canada | Canadian | 310295050001 | |||||
| BROWN, Robert Muirhead Birnie | Secrétaire | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | 153901810001 | |||||||
| CAMERON, Linda May | Secrétaire | Derbeth Park AB15 8TU Kingswells 14 Aberdeenshire | British | 135036050001 | ||||||
| JOHNSON, Ian | Secrétaire | John Wood House Greenwell Road, East Tullos AB12 3AX Aberdeen Aberdeenshire | British | 102664100004 | ||||||
| JONES, Iain Angus | Secrétaire | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland | 204012030001 | |||||||
| RYLANCE, Glenis Elaine | Secrétaire | 67 Elmfield Avenue TW11 8BX Teddington Middlesex | British | 89158560002 | ||||||
| BAGGS, James | Administrateur | John Wood House Greenwell Road, East Tullos AB12 3AX Aberdeen Aberdeenshire | Canada | Canadian | 186595500001 | |||||
| BENNETT, Terry Joseph | Administrateur | New Way G73 1DH Rutherglen 1 Glasgow United Kingdom | Canada | Canadian | 205302730001 | |||||
| BROADLEY, Stuart Richard | Administrateur | Invercrynoch Steading Maryculter AB12 5GX Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 96818620001 | |||||
| DINOZZI, Antonio Vincenzo | Administrateur | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | 255179660001 | |||||
| GILMAN, Nicholas Charles | Administrateur | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | England | British | 186518540001 | |||||
| GIOVANETTO, Casey Joseph | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland Scotland | Canada | Canadian | 310296230001 | |||||
| GOULET, Corey | Administrateur | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Canada | Canadian | 203910140001 | |||||
| HOPE, Gordon | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland | Scotland | British | 285553640001 | |||||
| LYMPANY, David Alexander | Administrateur | New Way G73 1DH Rutherglen 1 Glasgow United Kingdom | Canada | British | 239080000001 | |||||
| POURBAIX, Alexander John | Administrateur | 39 Silvergrove Crescent Nw Calgary Alberta T3b 4m6 Canada | Canada | Canadian | 75769740001 | |||||
| STEPHEN, Gary Laird | Administrateur | 287 Canterville Drive Sw Calgary Alberta T2w 3x9 Canada | Canada | Canadian | 74253430001 | |||||
| STEWART, Beverly | Administrateur | John Wood House Greenwell Road, East Tullos AB12 3AX Aberdeen Aberdeenshire | Canada | British | 169887990001 | |||||
| TATE, Kenneth | Administrateur | John Wood House Greenwell Road, East Tullos AB12 3AX Aberdeen Aberdeenshire | Canada | Canadian | 151406710001 | |||||
| TAYLOR, William | Administrateur | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Canada | Canadian | 194133570001 | |||||
| WATSON, Christopher Edward Milne | Administrateur | John Wood House Greenwell Road, East Tullos AB12 3AX Aberdeen Aberdeenshire | United Kingdom | British | 60315030002 | |||||
| WHITELAW, Christopher P | Administrateur | New Way Rutherglen G73 1DH Glasgow 1 Scotland | Canada | Canadian | 239079340001 | |||||
| WILCOX, Timothy George | Administrateur | c/o Wood Group Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Canada | Canadian | 193937470001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TRANSCANADA TURBINES (UK) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Wood Group Plc | 06 avr. 2016 | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Transcanada Pipelines Limtied | 06 avr. 2016 | 1st Street Sw Calgary 450 Alberta Canada | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Tc Energy Corporation | 06 avr. 2016 | 1st Street Sw T2P 5H1 Calgary 450 Alberta Canada | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0