MAXIE RICHARDS FOUNDATION

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMAXIE RICHARDS FOUNDATION
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société SC212660
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    • Autres activités de soins résidentiels n.c.a. (87900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    Adresse du siège social
    The King's Court Annexe
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    Scotland
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au08 nov. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation22 nov. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au08 nov. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Lorraine Mary Quigg en tant qu'administrateur le 26 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Sheena Maccallum Currie en tant qu'administrateur le 26 oct. 2025

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2024

    14 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Flat 2 King's Court Kames Tighnabruaich PA21 2BH Scotland à The King's Court Annexe Kames Tighnabruaich PA21 2BH le 23 janv. 2025

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Flat 2 the King's Court Flat 2 the King's Court Kames Tighnabruaich PA21 2BH Scotland à Flat 2 King's Court Kames Tighnabruaich PA21 2BH le 11 déc. 2024

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2023

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    14 pagesAA

    Cessation de la nomination de Annette Christian en tant que directeur le 06 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de West Cowal Manse Kames Tighnabruaich Argyll PA21 2AD Scotland à Flat 2 the King's Court Flat 2 the King's Court Kames Tighnabruaich PA21 2BH le 20 nov. 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Brian Joseph Leech en tant que directeur le 26 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Stephen Wishart en tant qu'administrateur le 22 févr. 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Clifford Jeremy Denovan en tant qu'administrateur le 18 mai 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2017

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARGE, Alastair Kenneth
    Otter Ferry
    PA21 SDH Tighnabruaich
    Evanachan
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Otter Ferry
    PA21 SDH Tighnabruaich
    Evanachan
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish91910001
    CURRIE, Sheena Maccallum
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    ScotlandBritish318194440001
    DENOVAN, Clifford Jeremy
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    ScotlandBritish269828030001
    MARTIN, Roger, Sir
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    ScotlandEnglish208786260001
    MITCHELL, David, Rev
    Kames
    PA21 2AD Tighnabruaich
    West Cowal Manse
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2AD Tighnabruaich
    West Cowal Manse
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish200877540001
    QUIGG, Lorraine Mary
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    ScotlandBritish300008480001
    WISHART, Stephen
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2BH Tighnabruaich
    The King's Court Annexe
    Scotland
    ScotlandScottish280067310001
    MCCULLOCH, George
    3 Sunningdale Avenue
    Newton Mearns
    G77 5PE Glasgow
    East Renfrewshire
    Secrétaire
    3 Sunningdale Avenue
    Newton Mearns
    G77 5PE Glasgow
    East Renfrewshire
    British1301510002
    MCFARLANE, William Stewart
    2d Southwood Court
    Rosemount Avenue, Newton Mearns
    G77 5TN Glasgow
    Lanarkshire
    Secrétaire
    2d Southwood Court
    Rosemount Avenue, Newton Mearns
    G77 5TN Glasgow
    Lanarkshire
    British65321100001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    ATKINSON, John Michael, Professor
    Greenhill
    Bishopbriggs
    G64 1LE Glasgow
    27
    Administrateur
    Greenhill
    Bishopbriggs
    G64 1LE Glasgow
    27
    United KingdomBritish136103380001
    BROUGH, David Thornaby
    Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    7
    Administrateur
    Craighirst Road
    Milngavie
    G62 7RG Glasgow
    7
    ScotlandBritish139875960001
    CHRISTIAN, Annette
    Ardlamont
    PA21 2AH Tighnabruaich
    Kilbride Farm
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Ardlamont
    PA21 2AH Tighnabruaich
    Kilbride Farm
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish201657510001
    DANESH, Booth Jon, Dr
    Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    168
    United Kingdom
    Administrateur
    Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    168
    United Kingdom
    ScotlandBritish133298980001
    DEVLIN, Brian
    19 Agnew Avenue
    ML5 3QD Coatbridge
    Lanarkshire
    Administrateur
    19 Agnew Avenue
    ML5 3QD Coatbridge
    Lanarkshire
    British72882400001
    HAGLINGTON, Caryl Anne
    29 Gleneagles Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3EG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Bar
    Administrateur
    29 Gleneagles Gardens
    Bishopbriggs
    G64 3EG Glasgow
    East Dunbartonshire
    Bar
    ScotlandBritish72882650001
    HAWTHORNE, Robert Edward
    Whin Avenue
    Barrhead
    G78 1JQ Glasgow
    20
    Scotland
    Administrateur
    Whin Avenue
    Barrhead
    G78 1JQ Glasgow
    20
    Scotland
    ScotlandBritish182668220001
    HENDERSON, Rose
    45 Iona Court
    House 13/1 Govan
    G51 2EY Glasgow
    Administrateur
    45 Iona Court
    House 13/1 Govan
    G51 2EY Glasgow
    British72881760001
    LEECH, Brian Joseph
    Ardlamont
    PA21 2AH Tighnabruaich
    Corra Farmhouse
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Ardlamont
    PA21 2AH Tighnabruaich
    Corra Farmhouse
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish125549500001
    MCCULLOCH, George
    3 Sunningdale Avenue
    Newton Mearns
    G77 5PE Glasgow
    East Renfrewshire
    Administrateur
    3 Sunningdale Avenue
    Newton Mearns
    G77 5PE Glasgow
    East Renfrewshire
    British1301510002
    MCFARLANE, Elizabeth
    2/R 23 Alexandra Avenue
    Lenzie
    G66 5BG Glasgow
    Administrateur
    2/R 23 Alexandra Avenue
    Lenzie
    G66 5BG Glasgow
    British72882570002
    MCGEACHIE, Kenneth
    Culzean Drive
    Mount Vernon
    G32 0TD Glasgow
    15
    Strathclyde
    Administrateur
    Culzean Drive
    Mount Vernon
    G32 0TD Glasgow
    15
    Strathclyde
    ScotlandBritish139876130001
    MCLEAN, Alexander
    Kames
    PA21 2AG Tighnabruaich
    Oaklea
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2AG Tighnabruaich
    Oaklea
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish201658270001
    MERCER, William
    Arnish Cottage
    Poll Bay
    PA25 8BA St.Catherine's
    Argyll
    Administrateur
    Arnish Cottage
    Poll Bay
    PA25 8BA St.Catherine's
    Argyll
    British74143610001
    MILROY, Edith
    Glebe Street
    KA13 7DA Kilwinning
    3
    Ayrshire
    Scotland
    Administrateur
    Glebe Street
    KA13 7DA Kilwinning
    3
    Ayrshire
    Scotland
    ScotlandBritish163227170001
    MORRISON, Agnes
    Eliot Terrace
    ML3 6SW Hamilton
    14
    Lanarkshire
    Scotland
    Administrateur
    Eliot Terrace
    ML3 6SW Hamilton
    14
    Lanarkshire
    Scotland
    ScotlandScottish164837970001
    PARKIN, Dorothy Anne
    Kames
    PA21 2AD Tighnabruaich
    West Cowal Manse
    Argyll
    Scotland
    Administrateur
    Kames
    PA21 2AD Tighnabruaich
    West Cowal Manse
    Argyll
    Scotland
    ScotlandBritish97933120001
    PENDLETON, Elizabeth
    30 Tweed Drive
    G61 1EJ Bearsden
    East Dunbartonshire
    Administrateur
    30 Tweed Drive
    G61 1EJ Bearsden
    East Dunbartonshire
    British93388960001
    PURVIS, Mary Cairns
    163 Shakespeare Avenue
    G81 3ET Clydebank
    Dunbartonshire
    Administrateur
    163 Shakespeare Avenue
    G81 3ET Clydebank
    Dunbartonshire
    British72882510001
    RADEMAN, Patricia Mary
    71 Causeyside Street
    PA1 1YT Paisley
    Renfrewshire
    Administrateur
    71 Causeyside Street
    PA1 1YT Paisley
    Renfrewshire
    British79224430001
    RICHARDS, Maxie Beatrice
    19 Dirleton Gate
    Bearsden
    G61 1NP Glasgow
    East Dunbartonshire
    Administrateur
    19 Dirleton Gate
    Bearsden
    G61 1NP Glasgow
    East Dunbartonshire
    ScotlandBritish72881830001
    STRIKER, Thomas Anthony
    24 Elm Drive , Burnside Park
    Chapelhall
    ML2 7PY Airdrie
    North Lanarkshire
    Administrateur
    24 Elm Drive , Burnside Park
    Chapelhall
    ML2 7PY Airdrie
    North Lanarkshire
    British72882430002
    VAUGHAN, David
    91 Hamilton Road
    ML1 3DG Motherwell
    Administrateur
    91 Hamilton Road
    ML1 3DG Motherwell
    United KingdomBritish55700730001
    WHITE, Robert Walter Charles
    1 Norby Road
    G11 7BL Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    1 Norby Road
    G11 7BL Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish192871930001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Administrateur désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour MAXIE RICHARDS FOUNDATION ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    08 nov. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0