SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social
    Numéro de société SC213517
    JuridictionÉcosse
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    • Activités de travail social sans hébergement pour les personnes âgées et handicapées (88100) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SIGHT ACTION15 janv. 200915 janv. 2009
    VISUAL IMPAIRMENT SERVICES HIGHLAND06 déc. 200006 déc. 2000

    Quels sont les derniers comptes de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au03 févr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation17 févr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au03 févr. 2024
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Changement d'adresse du siège social de Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ Scotland à Suite B, 4th Floor, Meridian Union Row Aberdeen AB10 1SA le 10 avr. 2024

    3 pagesAD01

    Ordonnance du tribunal dans une liquidation (et pièce jointe de l'ordonnance du tribunal)

    4 pagesWU01(Scot)

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Maureen Mary Macmillan en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Rob Polson en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David King en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Emily Elizabeth Mary Gray en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Murray Cochrane en tant que directeur le 31 déc. 2023

    1 pagesTM01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023

    23 pagesAA

    Nomination de Mr Scott Alan Murray en tant qu'administrateur le 21 nov. 2023

    2 pagesAP01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed sight action\certificate issued on 01/09/23
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name01 sept. 2023

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Nomination de Miss Lynsey Daniel en tant que secrétaire le 01 juil. 2023

    2 pagesAP03

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022

    26 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sandra May Elizabeth Ross en tant que secrétaire le 08 nov. 2022

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Beechwood House 69 - 71 Old Perth Road Raigmore Inverness Highland Region IV2 3JH à Robertson House Greenhill Street Dingwall IV15 9JQ le 15 août 2022

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Edward Murray Cochrane en tant qu'administrateur le 01 févr. 2022

    2 pagesAP01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2021

    23 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Grant en tant que directeur le 19 août 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Peter Fowler en tant que directeur le 11 mai 2021

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Grant en tant qu'administrateur le 09 mars 2021

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 03 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2020

    22 pagesAA

    Nomination de Mr David King en tant qu'administrateur le 10 nov. 2020

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DANIEL, Lynsey
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Secrétaire
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    310993760001
    MACLEAN, Angela Margaret
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Administrateur
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    ScotlandBritish93204940001
    MURRAY, Scott Alan
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    Administrateur
    Chattan Gardens
    IV12 4QP Nairn
    Dunevan
    Scotland
    United KingdomBritish173911240003
    ROWANTREE, Robert Ian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    Administrateur
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Suite B, 4th Floor, Meridian
    United KingdomBritish57180660001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Secrétaire
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    British57440560001
    MCLENAN, Sarah Louise
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Secrétaire
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    261749260001
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Secrétaire
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    British73180870001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secrétaire
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    169920830001
    ROSS, Sandra May Elizabeth
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Secrétaire
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    267631590001
    ROSS, Sandra
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Secrétaire
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    174219790001
    SPITTAL, Felix Thomas
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Secrétaire
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    164999560001
    BAINBRIDGE, Raymond
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Administrateur
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandBritish157900700001
    BOYLE, Nicholas Michael
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    Administrateur
    Windyhills Achlaschoille Farmhouse
    Farr
    IV2 6XG Inverness
    Invernesshire
    ScotlandBritish116796780001
    CAMPBELL, Hugh Macarthur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritish113911180001
    CHATTERTON, Jean, Dr
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritish199763500001
    COCHRANE, Edward Murray
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish162624860001
    CULLINGHAM, Terence James
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    Administrateur
    Churchill Drive
    IV15 9RD Dingwall
    11
    Ross-Shire
    ScotlandBritish97749010002
    CUMMING, Christina
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    72 Kenneth Street
    IV3 5PZ Inverness
    Inverness Shire
    British121428950001
    FOWLER, Alan Peter
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritish258273310001
    FRASER, James Robert Simpson
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    United KingdomBritish197996780001
    GRANT, Christopher
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    ScotlandBritish279588350001
    GRAY, Emily Elizabeth Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish218607290003
    HO-YEN, Darrel Orlando, Doctor
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritish183119510001
    JACK, Malcolm Lyall
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Administrateur
    Lismore Tower Brae
    Westhill
    IV1 2BW Inverness
    Scotland,UkBritish57440560001
    JOHN, David Phillip
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    69 - 71 Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandBritish166909770001
    KING, David
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish254314190001
    MACDONALD, Margaret
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    Administrateur
    13 Balconie Park
    Evanton
    IV16 9XD Dingwall
    Ross Shire
    ScotlandBritish97901380001
    MACKINNON, Iain
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    Administrateur
    Old Perth Road
    Raigmore
    IV2 3JH Inverness
    Beechwood House
    Highland Region
    Scotland
    ScotlandScottish179390360001
    MACLEAN, Elizabeth Anne
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    Administrateur
    Grianan
    Woodside Avenue
    PH26 3JR Grantown On Spey
    Morayshire
    ScotlandBritish27235670001
    MACMILLAN, Maureen Mary
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish26305820003
    MERCHANT, Joan Isobel Sinclair
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    3 Crown Circus
    IV2 3NH Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish73180870001
    MOORE, Raymond John Kentigern
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    Administrateur
    8 Abertarff Road
    IV2 3NW Inverness
    Inverness Shire
    ScotlandBritish90612420001
    PATERSON, David Weatherston
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    Administrateur
    Drumnadrochit
    Drumnadrochit
    IV63 6TZ Inverness
    Dalgregaig House
    United Kingdom
    ScotlandBritish150263780001
    POLSON, Rob
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    Administrateur
    Greenhill Street
    IV15 9JQ Dingwall
    Robertson House
    Scotland
    ScotlandBritish258273400001
    ROBERTSON, Michael Andrew
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    Administrateur
    38 Ardconnel Street
    Inverness
    IV2 3EX
    ScotlandScottish169250390001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    SIGHT ACTION SENSORY SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mars 2024Petition date
    28 mars 2024Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Callum Angus Carmichael
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    practitioner
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Graham David Smith
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    practitioner
    Suite B, 4th Floor Meridian
    Union Row
    AB10 1SA Aberdeen
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0