NO CATCH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNO CATCH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société SC214867
    JuridictionÉcosse
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NO CATCH LIMITED ?

    • (0502) /

    Où se situe NO CATCH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o GRANT THORNTON UK LLP
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NO CATCH LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JOHNSON SEAFARMS LIMITED17 janv. 200117 janv. 2001

    Quels sont les derniers comptes de NO CATCH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2005

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NO CATCH LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NO CATCH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Compte rendu de la réunion finale de la liquidation volontaire

    3 pages4.26(Scot)

    Avis de réunion finale des créanciers

    7 pages4.17(Scot)

    Avis de passage de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    11 pages2.25B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    9 pages2.20B(Scot)

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    11 pages2.20B(Scot)

    Nomination d'un administrateur

    6 pages2.11B(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    2 pages419a(Scot)

    legacy

    1 pages287

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Certificat de changement de nom

    Company name changed johnson seafarms LIMITED\certificate issued on 13/06/07
    2 pagesCERTNM

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    17 pagesAA

    legacy

    9 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return14 févr. 2007

    legacy

    363(288)

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution élective

    ELRES

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de NO CATCH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WRIGHT, Heather May
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    Secrétaire
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    BritishChartered Accountant72112170001
    FOULKES, John Harold
    Ellingham House
    79 Pittville Lawn
    GL52 2BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Ellingham House
    79 Pittville Lawn
    GL52 2BP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishCompany Director1657980008
    LLOYD, Michael Anthony
    4 Ravelston Place
    EH4 3DT Edinburgh
    Administrateur
    4 Ravelston Place
    EH4 3DT Edinburgh
    BritishCompany Director73967240001
    ROBINSON, Clive William
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    Administrateur
    16 Chislehurst Road
    TW10 6PW Richmond
    Surrey
    EnglandBritishDirector13438180002
    RZEPKOWSKI, Karol
    Helendale House
    Lerwick
    ZE1 0RG Shetland
    Administrateur
    Helendale House
    Lerwick
    ZE1 0RG Shetland
    United KingdomBritishProjects/Marketing93792360001
    WRIGHT, Heather May
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    Administrateur
    17 Galachlaw Shot
    EH10 7JF Edinburgh
    ScotlandBritishChartered Accountant72112170001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Secrétaire
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    BritishAccountant53832740002
    JOHNSON, Ivor Gilbert
    Havbruks
    ZE2 9QB Vidlin
    Shetland
    Secrétaire
    Havbruks
    ZE2 9QB Vidlin
    Shetland
    BritishSalmon Farmer46659920001
    VIGUIE, Laurent Louis Albert
    4 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    Secrétaire
    4 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    FrenchChairman103973630002
    OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    Secrétaire désigné
    24 Great King Street
    EH3 6QN Edinburgh
    900000010001
    CHANDLER, Andrew Philip
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    Administrateur
    30 Parkhurst Road
    DA5 1AR Bexley
    Kent
    United KingdomBritishAccountant53832740002
    HEATHCOTE, Jonathan Lister
    Pear Tree Farm
    Bradley Road Kirtling
    CB8 9JB Newmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Pear Tree Farm
    Bradley Road Kirtling
    CB8 9JB Newmarket
    Suffolk
    United KingdomBritishBanker160333180001
    JOHNSON, Angus
    Langara
    Vidlin
    ZE2 9QB Shetland
    Administrateur
    Langara
    Vidlin
    ZE2 9QB Shetland
    ScotlandBritishSalmon Farmer65832980002
    JOHNSON, Gordon
    Shalderslea
    Trondra
    ZE1 0XL Scalloway
    Shetland
    Administrateur
    Shalderslea
    Trondra
    ZE1 0XL Scalloway
    Shetland
    ScotlandBritishCompany Director127374300001
    JOHNSON, Ivor Gilbert
    Havbruks
    ZE2 9QB Vidlin
    Shetland
    Administrateur
    Havbruks
    ZE2 9QB Vidlin
    Shetland
    United KingdomBritishSalmon Farmer46659920001
    LEYLAND, Martin Thomas
    17 Cheyne Crescent
    Lerwick
    ZE1 0NS Shetland
    Administrateur
    17 Cheyne Crescent
    Lerwick
    ZE1 0NS Shetland
    United KingdomBritishAccountant91503550001
    MASON, Robert Sturdee
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    Administrateur
    Blindwell House
    OX29 6PN North Leigh
    Oxfordshire
    EnglandBritishBanker149738610001
    SMITH, David John
    16 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    16 Ridgmont Road
    AL1 3AF St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant97320620001
    VIGUIE, Laurent Louis Albert
    4 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    Administrateur
    4 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    FrenchCorporate Finance103973630002

    NO CATCH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Floating charge
    Créé le 18 oct. 2006
    Livré le 02 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Kaupthing Singe & Friedlander Limited
    • Kaupthing Singe & Friedlander Limited
    Transactions
    • 02 nov. 2006Enregistrement d'une charge (410)
    • 02 nov. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Ship mortgage
    Créé le 18 janv. 2005
    Livré le 26 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due including all sums owed in terms of a loan agreement dated 10 february 2004
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the fishing vessel known as "omega jsf" official number 908378.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Shetland Development Trust
    Transactions
    • 26 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Ship mortgage
    Créé le 11 janv. 2005
    Livré le 21 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due including all sums owed in terms of a loan agreement constituted by an offer of loan dated 10 february 2004 and the acceptance thereof
    Brèves mentions
    64/64TH shares in the fishing vessel known as "egilsay" official number 908377.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Shetland Development Trust
    Transactions
    • 21 janv. 2005Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)
    Floating charge
    Créé le 18 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    En cours
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Shetland Development Trust
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (410)
    • 07 nov. 2006Modification d'une charge flottante (466 Scot)
    • Présente des modifications à l'ordonnance: Oui
    Floating charge
    Créé le 16 mai 2002
    Livré le 27 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due
    Brèves mentions
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contient une charge flottante: Oui
    Personnes ayant droit
    • Angus Hansen Grains and Others as Trustees of Shetland Aquaculture Trust
    Transactions
    • 27 mai 2002Enregistrement d'une charge (410)
    • 25 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (419a)

    NO CATCH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    3
    DateType
    12 mai 2009Administration ended
    19 févr. 2008Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Daniel Robert Whiteley
    Grant Thornton House Melton Street
    G2 7JZ London
    practitioner
    Grant Thornton House Melton Street
    G2 7JZ London
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    practitioner
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    4
    DateType
    07 oct. 2015Dissolved on
    12 mai 2009Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7JZ
    practitioner
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7JZ
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Notesscottish-insolvency-info

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0